J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED

J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJ H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02123521
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    J H MINET REINSURANCE BROKERS LIMITED16 nov 198716 nov 1987
    STANDCITE LIMITED15 abr 198715 abr 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Paul Francis Clayden como director el 21 sept 2012

    1 páginasTM01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    14 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 sept 2011

    13 páginas4.68

    Cese del nombramiento de Yvonne Fisher como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 16 sept 2010

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de 8 Devonshire Square London EC2M 4PL el 04 oct 2010

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 ago 2010

    Estado de capital el 10 ago 2010

    • Capital: GBP 18,118,585
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    Nombramiento de Yvonne Jane Fisher como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Stephen Dudley Gale como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Edward Cruttwell como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Heap como director

    2 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    6 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSEC 2000 LIMITED
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Secretario corporativo
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    64208180001
    GALE, Stephen Dudley
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish152013590001
    ASPINALL, Nicholas
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    Secretario
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    British29662910003
    PYTCHES, Andrew Martyn
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    Secretario
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    British13889860001
    BARRIE, David Philip
    Showsley Farmhouse
    Showsley
    NN12 7NR Towcester
    Northamptonshire
    Director
    Showsley Farmhouse
    Showsley
    NN12 7NR Towcester
    Northamptonshire
    British14926200001
    BEGLEY, John Patrick
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Director
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985340001
    BUCKINGHAM, Philip
    6 Meridian Way, Amwell Way
    Great Amwell
    SG12 8DW Ware
    Director
    6 Meridian Way, Amwell Way
    Great Amwell
    SG12 8DW Ware
    British82552960001
    CLAYDEN, Paul Francis
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish138098080001
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British34367480002
    DOODES, Edward John
    67 Godfrey Way
    Great Dunmow
    CM6 2SE Dunmow
    Essex
    Director
    67 Godfrey Way
    Great Dunmow
    CM6 2SE Dunmow
    Essex
    British28939540001
    EDWARDS, Nicholas Steven
    The Crest Pennymead Rise
    KT24 5AL East Horsley
    Director
    The Crest Pennymead Rise
    KT24 5AL East Horsley
    British28939550002
    EWEN, Rodney John
    Brasted Place Farm
    Brasted
    SE9 5AP Westerham
    Kent
    Tn16 1je
    Director
    Brasted Place Farm
    Brasted
    SE9 5AP Westerham
    Kent
    Tn16 1je
    British14926220001
    FISHER, Yvonne Jane
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    EnglandBritish152086390001
    FODEN-PATTINSON, Nicholas Simon
    18 Stockenchurch Street
    SW6 3TR London
    Director
    18 Stockenchurch Street
    SW6 3TR London
    British3046640001
    HART, Nigel
    Vines Vines Lane
    TN11 9LT Hildenborough
    Kent
    Director
    Vines Vines Lane
    TN11 9LT Hildenborough
    Kent
    British37668040001
    HARVEY, Brian John
    31 Eastwood Road
    SS9 3AJ Leigh On Sea
    Essex
    Director
    31 Eastwood Road
    SS9 3AJ Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish13706550001
    HAYES, Bryan Joseph
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Director
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Irish49014750001
    HEAP, Michael Conrad
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British93892910002
    HILL, John Lawrence
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Director
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British663680003
    HOPE, Duncan Patrick Nicholson
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Director
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985300001
    HOPE, Ralph James D'Olier
    The Old Farmhouse
    Slugwash Lane
    RH17 7RQ Wivelsfield Green
    West Sussex
    Director
    The Old Farmhouse
    Slugwash Lane
    RH17 7RQ Wivelsfield Green
    West Sussex
    United KingdomBritish35654410001
    HVIDSTEN, Mark Trygue
    300 East 56 Street
    Apartment 20a
    NY 10022 New York
    Director
    300 East 56 Street
    Apartment 20a
    NY 10022 New York
    South African28868160003
    LAWSON, David John
    Chimneys Oakcroft Road
    KT14 6JH West Byfleet
    Surrey
    Director
    Chimneys Oakcroft Road
    KT14 6JH West Byfleet
    Surrey
    British54169840001
    MELLALIEU, Kevin John
    8 Grange Road
    Hazlemere
    HP15 7QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    8 Grange Road
    Hazlemere
    HP15 7QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British68083580001
    ORAM, William John
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    Director
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    United KingdomOther98212820001
    PARMENTER, Michael Peter
    37 Hawkwell Park Drive
    Hawkwell
    SS5 4HA Hockley
    Essex
    Director
    37 Hawkwell Park Drive
    Hawkwell
    SS5 4HA Hockley
    Essex
    British58496290001
    PHIPPS, Roger Charles Jacklin
    Middle House Shurlock Row
    RG10 0PS Reading
    Berkshire
    Director
    Middle House Shurlock Row
    RG10 0PS Reading
    Berkshire
    British28939570001
    PYTCHES, Andrew Martyn
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    Director
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    British13889860001
    ROSSOR, Michael Keith
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    Director
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    British55457000001
    WALL, David Neil
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Director
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British25408090002
    WOODHOUSE, Paul Richard
    The Grange
    Chipstead Lane
    TN13 2RD Chipstead
    Kent
    Director
    The Grange
    Chipstead Lane
    TN13 2RD Chipstead
    Kent
    EnglandBritish82942540001

    ¿Tiene J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of variation
    Creado el 17 feb 1997
    Entregado el 27 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All costs expenses obligations and other liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the security and trust deed and any loan or overdraft facility (as defined)
    Breve descripción
    All moneys (including brokerage )for the time beign standing to the credit of or pursuant to the bylelaw required to be paid into an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyd's as Trustee for Approved Banks (As Defined)
    Transacciones
    • 27 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 17 jun 1994
    Entregado el 06 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an indemnity dated 17TH june 1994 and this charge
    Breve descripción
    All rights,title and interest in all "designated securities" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge
    Creado el 17 jun 1994
    Entregado el 06 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an indemnity dated 17TH june 1994 (as defined)
    Breve descripción
    All monies held by the bank at its lloyd's building branch on acct/no.14877007.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security and trust deed.
    Creado el 17 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (nos of 1988) ("the byelaw") see form 345 for further details.
    Personas con derecho
    • Lloyds (A Statutory Corporation)
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 06 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 sept 2010Inicio de la liquidación
    26 dic 2012Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Profesional
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0