BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02125426 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 22 abr 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a Lodge Way House Lodge Way Harleston Road Northampton NN5 7UG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG United Kingdom a 45 Church Street Birmingham B3 2RT el 23 dic 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Notification de Travis Perkins Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Gammon & Smith Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 12 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2019 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Gammon & Smith Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Nigel Hampden Smith como director el 20 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Ian Cooper como director el 01 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Stephen Pike como secretario el 01 ago 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Tp Directors Ltd como director el 20 sept 2018 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 45 Church Street Birmingham B3 2RT a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG el 23 nov 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Alan Richard | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Certified Chartered Accountant | 137582690004 | ||||||||
TP DIRECTORS LTD | Director corporativo | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
BACON, Timothy Reginald | Secretario | 1 Wendover Gardens Christchurch GL50 2PA Cheltenham Gloucestershire | British | Accountant | 11336800001 | |||||||||
BARNETT, Graham Philip | Secretario | 67 Lone Pine Drive West Parley BH22 8LR Ferndown Dorset | British | 14644360002 | ||||||||||
PIKE, Andrew Stephen | Secretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | Company Director | 65678800002 | |||||||||
VALE, Ronald Edward | Secretario | 10 Greensleeves Avenue BH18 8BL Broadstone Dorset | British | 39756870001 | ||||||||||
BACON, Timothy Reginald | Director | 1 Wendover Gardens Christchurch GL50 2PA Cheltenham Gloucestershire | British | Accountant | 11336800001 | |||||||||
BARNETT, Graham Philip | Director | 67 Lone Pine Drive West Parley BH22 8LR Ferndown Dorset | British | Builder Merchant | 14644360002 | |||||||||
COOPER, Geoffrey Ian | Director | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 104472550001 | ||||||||
FISHER, Charles Murray | Director | Warneford House Sudgrove GL6 7JD Miserden Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 74765660002 | ||||||||
HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Director | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 72135950007 | ||||||||
MCKAY, Francis John | Director | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | Chief Executive | 78787530001 | |||||||||
ROPER, Bernard David | Director | 17 Charlton Drive Charlton Kings GL53 8ES Cheltenham Gloucestershire | England | British | Managing Director | 11336810001 | ||||||||
TRUMAN, John | Director | Vales Oasis Alfred Street DT11 7JN Blandford Forum Dorset | England | British | Builders Merchant | 39863480001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammon & Smith Limited | 06 abr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Travis Perkins Plc | 06 abr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 06 ene 1997 Entregado el 08 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 20 oct 1994 Entregado el 27 oct 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 3 july 1987 | |
Breve descripción Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge registered pursuant to an order of court dated 30/7/90 | Creado el 15 may 1990 Entregado el 03 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a unit 2 sunrise business park blandford forum dorset. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 03 jul 1987 Entregado el 14 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0