GE CAPITAL TLS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGE CAPITAL TLS LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02131552
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GE CAPITAL TLS LTD?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra GE CAPITAL TLS LTD?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE CAPITAL TLS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TLS PLC13 jun 199513 jun 1995
    TLS RANGE PLC21 abr 198921 abr 1989
    TLS RANGE SELF DRIVE LIMITED09 sept 198709 sept 1987
    EASTHART LIMITED13 may 198713 may 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GE CAPITAL TLS LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE CAPITAL TLS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2021

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2020

    10 páginasLIQ03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF el 17 oct 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 sept 2019

    LRESSP

    Cambio de datos del director Jonathan Lawrence John Gatt el 01 ago 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Shahryar Mufti el 01 ago 2019

    2 páginasCH01

    Estado de capital el 31 may 2019

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 14/05/2019
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 14 may 2019

    • Capital: GBP 161,042,597.5
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 02 may 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    32 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    capital

    Resoluciones

    Subdivide 28/03/2019
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Subdivisión de acciones el 28 mar 2019

    4 páginasSH02

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Modification des détails de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2019

    2 páginasPSC05

    Cessation de Ge Ese Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2019

    1 páginasPSC07

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de GE CAPITAL TLS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomMaltese228824220001
    MUFTI, Shahryar
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish215531750001
    MOYLE, Steven Taylor
    8 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    Cheshire
    Secretario
    8 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    Cheshire
    British53092470002
    STEWART, John Wyllie
    Greystoke
    Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    Greystoke
    Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    British995100002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretario corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish100238650001
    BEEVER, David Milton Maxwell
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    Director
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    United KingdomBritish35274610001
    BRADLEY, Richard Todd
    500 Patriots Way
    Newtown Square
    19073 Pennsylvania
    Usa
    Director
    500 Patriots Way
    Newtown Square
    19073 Pennsylvania
    Usa
    American54593440001
    BRINDLE, Philip Leigh
    21 Wrenpark Road
    Wingerworth
    S42 6RZ Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    21 Wrenpark Road
    Wingerworth
    S42 6RZ Chesterfield
    Derbyshire
    British14271560001
    BUCCI, John Vincent
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    Director
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    America81623160001
    BUSBY, Peter Stephen
    28 Hesketh Road
    PR9 9PD Southport
    Merseyside
    Director
    28 Hesketh Road
    PR9 9PD Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish73163760001
    CONWAY, James Denis
    45 Lanton Road
    Newlands
    G43 2SR Glasgow
    Director
    45 Lanton Road
    Newlands
    G43 2SR Glasgow
    British36615600001
    D'AMMASSA, Carl Mark
    The Smithy
    Bottoms Farm Warmingham Road
    CW1 4PJ Warmingham
    Director
    The Smithy
    Bottoms Farm Warmingham Road
    CW1 4PJ Warmingham
    British119207850001
    DE'ATH, Mark Robert
    4 Caxton Mews
    The Butts
    TW8 8BN Brentford
    Middlesex
    Director
    4 Caxton Mews
    The Butts
    TW8 8BN Brentford
    Middlesex
    British49303130003
    DELAMORE, Karen Ann
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136619480001
    DENVIR, Brian Anthony
    2/4 Dunscar Cottages
    Dunscar,Egerton
    BL7 9EP Bolton
    Lancashire
    Director
    2/4 Dunscar Cottages
    Dunscar,Egerton
    BL7 9EP Bolton
    Lancashire
    British32346480001
    EVANS, Marshall Owen
    Warwick House
    47 Stewkley Road Wing
    LU7 0NJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    Warwick House
    47 Stewkley Road Wing
    LU7 0NJ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    United KingdomBritish42930970001
    FAST, Robert Alain
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    NetherlandsAmerican89843360002
    GRIFFIN, Kevin Thomas
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish122136120001
    HODGKISS, Roger Hilton
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    Director
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    United KingdomBritish76993260001
    JULIANO, Alan Joseph
    Museumplein 7-11
    FOREIGN Amsterdam 1071 Dj
    Netherland
    Director
    Museumplein 7-11
    FOREIGN Amsterdam 1071 Dj
    Netherland
    American125150100001
    MANNION, Eileen Frances
    74 Church Street
    SK13 7RN Old Glossop
    Derbyshire
    Director
    74 Church Street
    SK13 7RN Old Glossop
    Derbyshire
    British119358410001
    MCENROE, Malachy
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Irish139465450001
    MILLAY, Roger Foster
    1323 Shadow Oak Drive
    PA 19355 Malvern
    Usa
    Director
    1323 Shadow Oak Drive
    PA 19355 Malvern
    Usa
    American56302140001
    MILLER, Clive John
    Glenfield 234 Mottram Road
    SK15 2RY Stalybridge
    Cheshire
    Director
    Glenfield 234 Mottram Road
    SK15 2RY Stalybridge
    Cheshire
    EnglandBritish585590001
    MINETT, Timothy William
    Ivy End,
    Wattlesborough
    SY5 9EA Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Ivy End,
    Wattlesborough
    SY5 9EA Shrewsbury
    Shropshire
    British141648470001
    OLIVER, John Lancaster
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    Director
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    British87846400001
    PAREKH, Girish
    Fairhaven
    1 Kings Drive Fulwood
    PR2 3HN Preston
    Director
    Fairhaven
    1 Kings Drive Fulwood
    PR2 3HN Preston
    British84067630001
    ROBERTS, Peter Arnold
    Beechwood Cottage 64 Crouchley Lane
    WA13 0AT Lymm
    Cheshire
    Director
    Beechwood Cottage 64 Crouchley Lane
    WA13 0AT Lymm
    Cheshire
    British9290450001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    STEED, Gareth Andrew Richard
    27 Brooklawn Drive
    M20 3GY Manchester
    Lancashire
    Director
    27 Brooklawn Drive
    M20 3GY Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish242558020001
    STEWART, John Wyllie
    Greystoke
    Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Greystoke
    Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    British995100002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GE CAPITAL TLS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1329406
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1500252
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GE CAPITAL TLS LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    02 may 201701 dic 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene GE CAPITAL TLS LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment by way of security and charge of sub-leases
    Creado el 21 jul 1995
    Entregado el 03 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the acquisition documents and the security documents on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title & interest in & to the charged property and all moneys payable the net proceeds of any claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • At&T Capital Limited
    Transacciones
    • 03 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 abr 1995
    Entregado el 01 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage land and buildings lying to the south west of king william street, salford t/no. GM672020 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 06 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 nov 1994
    Entregado el 17 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's interest in all motor vehicles ("the vehicles") together with the benefit of all contracts securities guarantees and indemnities and all proceeds of sale, insurance claims and debts etc. due to the company in relation to any of the vehicles or contracts. Floating charge all the company's interest in the motor vehicles and equipment mentioned above and the proceeds of sale insurance claims and debts etc. in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • United Dominions Trust Limited
    Transacciones
    • 17 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A first fixed charge
    Creado el 22 jun 1994
    Entregado el 25 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreements or lease agreements entered into
    Breve descripción
    First fixed charge all sub-lease agreements entered into at any time by the company with customers of the company relating to goods owned by the company but let by mbf to the company under hire purchase agreements or lease agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transacciones
    • 25 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 may 1994
    Entregado el 19 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1) land and buildings on the south west side of victory road blackpool t/n la 411266. 2) land and buildings on the north east side of gorton blackpool t/n la 696245. 3) land and buildings k/a 102 gorton street blackpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 28 feb 1994
    Entregado el 02 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All present and future contracts of lease or hire made by the company in relation to all or any goods which are in the process of becoming acquired by the company from the owner.
    Personas con derecho
    • Ca Industrial Finance Limited
    Transacciones
    • 02 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 30 nov 1987
    Entregado el 11 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the west side of chalfont street, salford greater manchester (see form 395 for full property details) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1987Registro de una carga
    • 22 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 nov 1987
    Entregado el 07 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1987Registro de una carga
    • 06 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GE CAPITAL TLS LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 ene 2023Fecha prevista de disolución
    26 sept 2019Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0