GE CAPITAL TLS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | GE CAPITAL TLS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02131552 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GE CAPITAL TLS LTD?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra GE CAPITAL TLS LTD?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE CAPITAL TLS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TLS PLC | 13 jun 1995 | 13 jun 1995 |
| TLS RANGE PLC | 21 abr 1989 | 21 abr 1989 |
| TLS RANGE SELF DRIVE LIMITED | 09 sept 1987 | 09 sept 1987 |
| EASTHART LIMITED | 13 may 1987 | 13 may 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GE CAPITAL TLS LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE CAPITAL TLS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2021 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2020 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 páginas | AD03 | ||||||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 páginas | AD02 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF el 17 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Jonathan Lawrence John Gatt el 01 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Shahryar Mufti el 01 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital el 31 may 2019
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 14 may 2019
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 32 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Subdivisión de acciones el 28 mar 2019 | 4 páginas | SH02 | ||||||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||
Cessation de Ge Ese Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GE CAPITAL TLS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GATT, Jonathan Lawrence John | Director | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Maltese | 228824220001 | |||||||||
| MUFTI, Shahryar | Director | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 215531750001 | |||||||||
| MOYLE, Steven Taylor | Secretario | 8 Lyme Road Disley SK12 2LL Stockport Cheshire | British | 53092470002 | ||||||||||
| STEWART, John Wyllie | Secretario | Greystoke Fletsand Road SK9 2AB Wilmslow Cheshire | British | 995100002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| BEADLE, Paul Laurence | Director | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 100238650001 | |||||||||
| BEEVER, David Milton Maxwell | Director | Warren Farm House South Drive GU25 4JS Wentworth Surrey | United Kingdom | British | 35274610001 | |||||||||
| BRADLEY, Richard Todd | Director | 500 Patriots Way Newtown Square 19073 Pennsylvania Usa | American | 54593440001 | ||||||||||
| BRINDLE, Philip Leigh | Director | 21 Wrenpark Road Wingerworth S42 6RZ Chesterfield Derbyshire | British | 14271560001 | ||||||||||
| BUCCI, John Vincent | Director | Summerhill Steels Lane, Oxshott KT22 0QQ Leatherhead Surrey | America | 81623160001 | ||||||||||
| BUSBY, Peter Stephen | Director | 28 Hesketh Road PR9 9PD Southport Merseyside | United Kingdom | British | 73163760001 | |||||||||
| CONWAY, James Denis | Director | 45 Lanton Road Newlands G43 2SR Glasgow | British | 36615600001 | ||||||||||
| D'AMMASSA, Carl Mark | Director | The Smithy Bottoms Farm Warmingham Road CW1 4PJ Warmingham | British | 119207850001 | ||||||||||
| DE'ATH, Mark Robert | Director | 4 Caxton Mews The Butts TW8 8BN Brentford Middlesex | British | 49303130003 | ||||||||||
| DELAMORE, Karen Ann | Director | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136619480001 | |||||||||
| DENVIR, Brian Anthony | Director | 2/4 Dunscar Cottages Dunscar,Egerton BL7 9EP Bolton Lancashire | British | 32346480001 | ||||||||||
| EVANS, Marshall Owen | Director | Warwick House 47 Stewkley Road Wing LU7 0NJ Leighton Buzzard Bedfordshire | United Kingdom | British | 42930970001 | |||||||||
| FAST, Robert Alain | Director | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | Netherlands | American | 89843360002 | |||||||||
| GRIFFIN, Kevin Thomas | Director | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | 122136120001 | |||||||||
| HODGKISS, Roger Hilton | Director | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | United Kingdom | British | 76993260001 | |||||||||
| JULIANO, Alan Joseph | Director | Museumplein 7-11 FOREIGN Amsterdam 1071 Dj Netherland | American | 125150100001 | ||||||||||
| MANNION, Eileen Frances | Director | 74 Church Street SK13 7RN Old Glossop Derbyshire | British | 119358410001 | ||||||||||
| MCENROE, Malachy | Director | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | Irish | 139465450001 | ||||||||||
| MILLAY, Roger Foster | Director | 1323 Shadow Oak Drive PA 19355 Malvern Usa | American | 56302140001 | ||||||||||
| MILLER, Clive John | Director | Glenfield 234 Mottram Road SK15 2RY Stalybridge Cheshire | England | British | 585590001 | |||||||||
| MINETT, Timothy William | Director | Ivy End, Wattlesborough SY5 9EA Shrewsbury Shropshire | British | 141648470001 | ||||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Director | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | 87846400001 | ||||||||||
| PAREKH, Girish | Director | Fairhaven 1 Kings Drive Fulwood PR2 3HN Preston | British | 84067630001 | ||||||||||
| ROBERTS, Peter Arnold | Director | Beechwood Cottage 64 Crouchley Lane WA13 0AT Lymm Cheshire | British | 9290450001 | ||||||||||
| SMITH, Neil Campbell | Director | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183029170001 | |||||||||
| STEED, Gareth Andrew Richard | Director | 27 Brooklawn Drive M20 3GY Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 242558020001 | |||||||||
| STEWART, John Wyllie | Director | Greystoke Fletsand Road SK9 2AB Wilmslow Cheshire | British | 995100002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GE CAPITAL TLS LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Ese Uk Limited | 06 abr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Key Leasing Limited | 06 abr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GE CAPITAL TLS LTD?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 02 may 2017 | 01 dic 2017 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene GE CAPITAL TLS LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment by way of security and charge of sub-leases | Creado el 21 jul 1995 Entregado el 03 ago 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the acquisition documents and the security documents on any account whatsoever | |
Breve descripción All right title & interest in & to the charged property and all moneys payable the net proceeds of any claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 26 abr 1995 Entregado el 01 may 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage land and buildings lying to the south west of king william street, salford t/no. GM672020 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 14 nov 1994 Entregado el 17 nov 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All the company's interest in all motor vehicles ("the vehicles") together with the benefit of all contracts securities guarantees and indemnities and all proceeds of sale, insurance claims and debts etc. due to the company in relation to any of the vehicles or contracts. Floating charge all the company's interest in the motor vehicles and equipment mentioned above and the proceeds of sale insurance claims and debts etc. in relation thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A first fixed charge | Creado el 22 jun 1994 Entregado el 25 jun 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreements or lease agreements entered into | |
Breve descripción First fixed charge all sub-lease agreements entered into at any time by the company with customers of the company relating to goods owned by the company but let by mbf to the company under hire purchase agreements or lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 11 may 1994 Entregado el 19 may 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1) land and buildings on the south west side of victory road blackpool t/n la 411266. 2) land and buildings on the north east side of gorton blackpool t/n la 696245. 3) land and buildings k/a 102 gorton street blackpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 28 feb 1994 Entregado el 02 mar 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All present and future contracts of lease or hire made by the company in relation to all or any goods which are in the process of becoming acquired by the company from the owner. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 30 nov 1987 Entregado el 11 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on the west side of chalfont street, salford greater manchester (see form 395 for full property details) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 nov 1987 Entregado el 07 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene GE CAPITAL TLS LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0