VICTIM SUPPORT

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICTIM SUPPORT
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 02158780
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICTIM SUPPORT?

    • Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.p. (88990) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra VICTIM SUPPORT?

    Dirección de la sede social
    Building 3 Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICTIM SUPPORT?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NATIONAL ASSOCIATION OF VICTIMS SUPPORT SCHEMES28 ago 198728 ago 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICTIM SUPPORT?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para VICTIM SUPPORT?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 feb 2027
    Próxima declaración de confirmación vence15 feb 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 feb 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICTIM SUPPORT?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Sudipto Chatterjee como director el 26 feb 2026

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 páginasRP01AP01

    Cambio de datos del director Ms Clarisse Emilia Mallem el 23 ene 2026

    2 páginasCH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025

    64 páginasAA

    Cambio de datos del director Ms Marion Elizabeth Richards el 16 oct 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Martyn Herward como secretario el 04 jul 2025

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Sahreen Safdar como secretario el 04 jul 2025

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Yvonne Mary Thomas como director el 07 abr 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew David Tivey como director el 07 abr 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Ms Sahreen Safdar el 10 ene 2025

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Sudeep Chatterjee el 10 ene 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Sahreen Safdar como secretario el 10 ene 2025

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David Fowler como secretario el 09 ene 2025

    1 páginasTM02

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024

    64 páginasAA

    Nombramiento de Ms Marion Elizabeth Richards como director el 06 dic 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Onikosi como director el 06 dic 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kathryn Adkins como director el 06 dic 2024

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Ms Clarisse Emilia Mallem el 18 sept 2024

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Building 3, Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA Wales a Building 3 Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA el 18 sept 2024

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Ms Rachel Onikosi el 05 sept 2024

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Debbie Mary Goldsmith el 09 ago 2024

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Building 3, Eastern Business Park Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA Wales a Building 3, Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA el 09 ago 2024

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Professor Claire Elizabeth Collins como director el 20 mar 2024

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de VICTIM SUPPORT?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HERWARD, Martyn
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Secretario
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    337655910001
    COLLINS, Claire Elizabeth, Professor
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish261089390002
    EVANS, Helen Gail
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish235194140001
    GASCOIGNE, Angela Mary
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    WalesBritish133418440002
    GILLATT, Debbie Mary
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3,
    Wales
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3,
    Wales
    EnglandBritish305350220002
    GREEN, Caroline Inez
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish316941810001
    HAMILTON-STANLEY, Amanda
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish128721240001
    MOUREY, Clarisse Emilia
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandFrench215497630002
    RICHARDS, Marion Elizabeth
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish208314200001
    STEEN, Susan
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish319630360001
    THOMAS, Yvonne Mary
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish194601710002
    CASTLE, John Mark
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Secretario
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    188866000001
    FOWLER, David
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Secretario
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    315114440001
    GUY, Gillian
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Secretario
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    British60914830001
    KHAN, Javed
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Secretario
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    155122960001
    KINSELLA, Christopher Joseph
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Secretario
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    202398250001
    MOUSKIS, Pauline Joan
    Bridge Street
    DE1 3HZ Derby
    1
    England
    Secretario
    Bridge Street
    DE1 3HZ Derby
    1
    England
    286560130001
    REEVES, Helen May, Dame
    15a Blackheath Grove
    SE3 0DQ London
    Secretario
    15a Blackheath Grove
    SE3 0DQ London
    British78989520001
    RICH, Carolyn
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Ground Floor, Building 3, Eastern Business Park
    Wales
    Secretario
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Ground Floor, Building 3, Eastern Business Park
    Wales
    289337370001
    SAFDAR, Sahreen
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Secretario
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    331084760001
    SILCOCK, Anthony Gerard
    50 Banner Street
    EC1Y 8ST London
    Octavia House
    England
    Secretario
    50 Banner Street
    EC1Y 8ST London
    Octavia House
    England
    239735820001
    ADKINS, Kathryn
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish252531160002
    AHMED, Imran
    Bridge Street
    DE1 3HZ Derby
    1
    England
    Director
    Bridge Street
    DE1 3HZ Derby
    1
    England
    EnglandBritish215734720002
    BAILEY, Douglas
    3 Gelli Deg
    Bryncoch
    SA10 7PL Neath
    West Glamorgan
    Director
    3 Gelli Deg
    Bryncoch
    SA10 7PL Neath
    West Glamorgan
    British36823190001
    BARDELL, Roger Charles Walter
    36 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Director
    36 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    British11710930001
    BELLIS, John Benjamin
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Director
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    United KingdomBritish112027320003
    BLISS, Glynis Geraldine
    4 Barker Road
    Earls Barton
    NN6 0PA Northampton
    Northamptonshire
    Director
    4 Barker Road
    Earls Barton
    NN6 0PA Northampton
    Northamptonshire
    British57730400001
    BROADER, Joan Mary Bridget
    40 Sunnyside Street
    BT7 3EX Belfast
    County Antrim
    Director
    40 Sunnyside Street
    BT7 3EX Belfast
    County Antrim
    Irish31431510001
    CALDWELL, Sandra Mary
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Director
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    EnglandBritish65438630001
    CHAPMAN, Colin Michael
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Director
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    United KingdomBritish128184770001
    CHATTERJEE, Sudipto
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    Director
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandIndian319630240002
    CHICK, Ronald Vincent
    5 Carver Road
    SE24 9LS London
    Director
    5 Carver Road
    SE24 9LS London
    British31431440001
    CHIPPENDALE, Ian Hugh
    Apartment 610
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    Director
    Apartment 610
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    United KingdomBritish10033650006
    CLARK-GLASS, Mary Burnell
    The Old Curatage 6 The Square
    BT26 6AG Hillsborough
    County Down
    Director
    The Old Curatage 6 The Square
    BT26 6AG Hillsborough
    County Down
    British61810210001
    COLL, Sean
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    Director
    Hallam Street
    W1W 6JL London
    Hallam House 56-60
    IrelandIrish86555390001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para VICTIM SUPPORT?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    01 feb 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0