VICTIM SUPPORT
Visión general
| Nombre de la empresa | VICTIM SUPPORT |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 02158780 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VICTIM SUPPORT?
- Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.p. (88990) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra VICTIM SUPPORT?
| Dirección de la sede social | Building 3 Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICTIM SUPPORT?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NATIONAL ASSOCIATION OF VICTIMS SUPPORT SCHEMES | 28 ago 1987 | 28 ago 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VICTIM SUPPORT?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para VICTIM SUPPORT?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cu áles son las últimas presentaciones para VICTIM SUPPORT?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Sudipto Chatterjee como director el 26 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 páginas | RP01AP01 | ||
Cambio de datos del director Ms Clarisse Emilia Mallem el 23 ene 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 64 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Ms Marion Elizabeth Richards el 16 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Martyn Herward como secretario el 04 jul 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Sahreen Safdar como secretario el 04 jul 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Yvonne Mary Thomas como director el 07 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew David Tivey como director el 07 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Ms Sahreen Safdar el 10 ene 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mr Sudeep Chatterjee el 10 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Ms Sahreen Safdar como secretario el 10 ene 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de David Fowler como secretario el 09 ene 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 64 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Marion Elizabeth Richards como director el 06 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Rachel Onikosi como director el 06 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kathryn Adkins como director el 06 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Ms Clarisse Emilia Mallem el 18 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Building 3, Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA Wales a Building 3 Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA el 18 sept 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Ms Rachel Onikosi el 05 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Debbie Mary Goldsmith el 09 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Building 3, Eastern Business Park Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA Wales a Building 3, Wern Fawr Lane Old St. Mellons Cardiff CF3 5EA el 09 ago 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Professor Claire Elizabeth Collins como director el 20 mar 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de VICTIM SUPPORT?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERWARD, Martyn | Secretario | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | 337655910001 | |||||||
| COLLINS, Claire Elizabeth, Professor | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 261089390002 | |||||
| EVANS, Helen Gail | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 235194140001 | |||||
| GASCOIGNE, Angela Mary | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | Wales | British | 133418440002 | |||||
| GILLATT, Debbie Mary | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3, Wales | England | British | 305350220002 | |||||
| GREEN, Caroline Inez | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 316941810001 | |||||
| HAMILTON-STANLEY, Amanda | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 128721240001 | |||||
| MOUREY, Clarisse Emilia | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | French | 215497630002 | |||||
| RICHARDS, Marion Elizabeth | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 208314200001 | |||||
| STEEN, Susan | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 319630360001 | |||||
| THOMAS, Yvonne Mary | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 194601710002 | |||||
| CASTLE, John Mark | Secretario | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | 188866000001 | |||||||
| FOWLER, David | Secretario | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | 315114440001 | |||||||
| GUY, Gillian | Secretario | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | British | 60914830001 | ||||||
| KHAN, Javed | Secretario | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | 155122960001 | |||||||
| KINSELLA, Christopher Joseph | Secretario | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | 202398250001 | |||||||
| MOUSKIS, Pauline Joan | Secretario | Bridge Street DE1 3HZ Derby 1 England | 286560130001 | |||||||
| REEVES, Helen May, Dame | Secretario | 15a Blackheath Grove SE3 0DQ London | British | 78989520001 | ||||||
| RICH, Carolyn | Secretario | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Ground Floor, Building 3, Eastern Business Park Wales | 289337370001 | |||||||
| SAFDAR, Sahreen | Secretario | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | 331084760001 | |||||||
| SILCOCK, Anthony Gerard | Secretario | 50 Banner Street EC1Y 8ST London Octavia House England | 239735820001 | |||||||
| ADKINS, Kathryn | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | British | 252531160002 | |||||
| AHMED, Imran | Director | Bridge Street DE1 3HZ Derby 1 England | England | British | 215734720002 | |||||
| BAILEY, Douglas | Director | 3 Gelli Deg Bryncoch SA10 7PL Neath West Glamorgan | British | 36823190001 | ||||||
| BARDELL, Roger Charles Walter | Director | 36 Parkway Gidea Park RM2 5NT Romford Essex | British | 11710930001 | ||||||
| BELLIS, John Benjamin | Director | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | United Kingdom | British | 112027320003 | |||||
| BLISS, Glynis Geraldine | Director | 4 Barker Road Earls Barton NN6 0PA Northampton Northamptonshire | British | 57730400001 | ||||||
| BROADER, Joan Mary Bridget | Director | 40 Sunnyside Street BT7 3EX Belfast County Antrim | Irish | 31431510001 | ||||||
| CALDWELL, Sandra Mary | Director | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | England | British | 65438630001 | |||||
| CHAPMAN, Colin Michael | Director | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | United Kingdom | British | 128184770001 | |||||
| CHATTERJEE, Sudipto | Director | Wern Fawr Lane Old St. Mellons CF3 5EA Cardiff Building 3 United Kingdom | England | Indian | 319630240002 | |||||
| CHICK, Ronald Vincent | Director | 5 Carver Road SE24 9LS London | British | 31431440001 | ||||||
| CHIPPENDALE, Ian Hugh | Director | Apartment 610 8 Dean Ryle Street SW1P 4DA London | United Kingdom | British | 10033650006 | |||||
| CLARK-GLASS, Mary Burnell | Director | The Old Curatage 6 The Square BT26 6AG Hillsborough County Down | British | 61810210001 | ||||||
| COLL, Sean | Director | Hallam Street W1W 6JL London Hallam House 56-60 | Ireland | Irish | 86555390001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para VICTIM SUPPORT?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 01 feb 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0