BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02160383 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
- Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOUIS TAYLOR LIMITED | 22 sept 1987 | 22 sept 1987 |
| NORBARN LIMITED | 02 sept 1987 | 02 sept 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 25 jul 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Mundy como director el 10 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Aitken como director el 06 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Angel Square Manchester M60 0AG a Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL el 14 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Adnett como director el 20 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Aitken como director el 20 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Michael Miller como director el 20 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Mundy como director el 20 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clare Louise Gosling como director el 20 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Clive Whitehead como secretario el 30 mar 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brona Rose Mckeown como secretario el 30 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Brona Rose Mckeown como secretario el 19 dic 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katy Jane Arnold como secretario el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITEHEAD, David Clive | Secretario | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 196734950001 | |||||||
| ADNETT, Richard John | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 201058920001 | |||||
| MILLER, David Michael | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat United Kingdom | England | British | 201054530001 | |||||
| ARNOLD, Katy Jane | Secretario | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 192228430001 | |||||||
| GREEN, Robin Sinclair | Secretario | 9 Buckland Grove New Park ST4 8UG Trentham Staffordshire | British | 5782770001 | ||||||
| MCKEOWN, Brona Rose | Secretario | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 193731110001 | |||||||
| MEDFORD, Paul Derek | Secretario | 25 Bromley Drive CW4 7AX Holmes Chapel Cheshire | British | 123495670001 | ||||||
| MOSS, Susan | Secretario | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | 153016850001 | |||||||
| PLANT, Charles Roy | Secretario | 10 Eleanor View ST5 3SD Newcastle Staffordshire | British | 18132240002 | ||||||
| WADE, Patricia Anne | Secretario | Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | 147831160001 | |||||||
| AITKEN, Stephen | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British,Australian | 188712540001 | |||||
| ALLEN, Stuart James | Director | Tyme Cottage Bourne Court Hilderstone ST15 8XS Stone Staffordshire | British | 29297340001 | ||||||
| BAYLEY, Trevor John | Director | Woodside Clay Lake Endon ST9 9DD Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 804490002 | |||||
| BERRIMAN, David, Sir | Director | Leigh House High Street Leigh TN11 8RH Tonbridge Kent | British | 35079310001 | ||||||
| FENTON, John Gilbert | Director | Chestnut Tree House Puddy Lane Stanley ST9 9LU Stoke On Trent Staffordshire | British | 17937400001 | ||||||
| GOSLING, Clare Louise | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||
| GREEN, Robin Sinclair | Director | 9 Buckland Grove New Park ST4 8UG Trentham Staffordshire | British | 5782770001 | ||||||
| GRIFFITHS, John Ronald | Director | Fairhurst 5 Meadway Prestbury SK10 4DF Macclesfield Cheshire | British | 5779490001 | ||||||
| HEYWOOD, David George | Director | Finials Cotes ST15 0QQ Stone Staffordshire | England | British | 106393630001 | |||||
| HILL, John Lawrence | Director | Warwick Lodge 10 Warwicks Bench GU1 3TG Guildford Surrey | British | 1226130001 | ||||||
| HODSON, Richard Stuart | Director | Trebryn Milwich ST18 0EG Stafford Staffordshire | British | 67809730001 | ||||||
| HORNSEY, Nicholas Morrell | Director | 10 Roseville Drive CW12 3LU Congleton Cheshire | British | 53322950001 | ||||||
| JONES, Stephen Samuel | Director | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 187185730001 | |||||
| KERNS, Peter William | Director | 26 Swinhoe Place Hob Hey Lane WA3 4NE Culcheth Cheshire | United Kingdom | British | 67171290002 | |||||
| LEE, Phillip Andrew | Director | 11 Badger Road SK10 4JG Prestbury Cheshire | United Kingdom | British | 89215420001 | |||||
| MCCARTHY, David James | Director | Far End Sheepscombe GL6 7RL Stroud Knapp House Gloucestershire | England | British | 91557750002 | |||||
| MEDFORD, Paul Derek | Director | 25 Bromley Drive CW4 7AX Holmes Chapel Cheshire | British | 123495670001 | ||||||
| MUNDY, Daniel | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 189420920001 | |||||
| NEWBY, William Edward | Director | c/o Governance Dept, 5th Floor Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | 140446620001 | |||||
| PLANT, Charles Roy | Director | 10 Eleanor View ST5 3SD Newcastle Staffordshire | British | 18132240002 | ||||||
| RAWLINSON, Neil | Director | Willgate House Green Lane ST13 8PN Rudyard Nr Leek Staffordshire | British | 29189040001 | ||||||
| ROBERTS, Stuart Anthony | Director | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | United Kingdom | English | 168767590001 | |||||
| RUSSELL, Andrew Nicholas | Director | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 91395820001 | |||||
| SHAW, Francis Michael | Director | Rock House 711 Cheadle Road Wetley Rocks ST9 0BA Stoke On Trent Staffordshire | British | 5779480001 | ||||||
| STOW, Graham Harold | Director | The Hawthorns Roston DE6 2EH Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | 49223530002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Co-Operative Bank Plc | 06 abr 2016 | 1 Balloon Street M60 4EP Manchester PO BOX 101 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BRITANNIA ESTATE AGENTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0