SYBASE (UK) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SYBASE (UK) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02175260 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SYBASE (UK) LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra SYBASE (UK) LIMITED?
Dirección de la sede social | Sybase Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYBASE (UK) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SYBASE SOFTWARE LIMITED | 08 oct 1987 | 08 oct 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SYBASE (UK) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYBASE (UK) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter David como director el 02 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Julian David Hillman como director el 07 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Harald Winkler como director el 02 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Harald Winkler el 01 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christian Jehle el 01 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter David el 01 jun 2016 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Julian David Hillman el 01 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christian Jehle como director el 26 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Peter David como director el 11 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elena Shishkina como director el 11 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Matthews como secretario el 24 dic 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2013 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 319 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Estado de capital el 06 dic 2013
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SYBASE (UK) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEHLE, Christian | Director | Bedfont Road TW14 8HD Feltham Clockhouse Place Middlesex England | England | German | Chief Financial Officer Uk & Ireland | 204347190001 | ||||||||
BOWDEN, Terence Richard | Secretario | The Firs Wilkins Green Lane AL10 9RT Hatfield Hertfordshire | British | Finance Director | 68697000001 | |||||||||
CARTER SHAW, Jonathan | Secretario | 9 Clarefield Drive SL6 5DW Maidenhead Berkshire | British | Solicitor | 79566640004 | |||||||||
CARTER SHAW, Jonathan | Secretario | 9 Clarefield Drive SL6 5DW Maidenhead Berkshire | British | Solicitor | 79566640004 | |||||||||
COLLET, Helle | Secretario | Flat No 7 5 Cornwall Gardens SW7 4AJ London St James' House | Danish | Solicitor | 116344290003 | |||||||||
FORD, Sarah Ann | Secretario | Frenchmens Creek High Road SL6 9JS Cookham Berkshire | British | 103703770001 | ||||||||||
JONES, Stephen Gareth | Secretario | 4 Peel Gardens Kingsclere RG15 8SB Newbury Berkshire | British | Accountant | 45714720001 | |||||||||
LEONARD, Philip | Secretario | Sybase Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire | 160771060001 | |||||||||||
MATTHEWS, Helen | Secretario | Sybase Court Crown Lane SL6 8QZ Maidenhead Berkshire | 164142400001 | |||||||||||
MOREY, Anthony Raymond | Secretario | Trefeddian Frimley Hall Drive GU15 2BE Camberley Surrey | British | Director | 32510520001 | |||||||||
WALTON, Nicholas David | Secretario | 14 Shire Avenue GU51 2TB Fleet Hampshire | British | Chartered Accountant | 68048710001 | |||||||||
ROBINSON SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Howard House 70 Baker Street KT13 8AL Weybridge Surrey | 7975740001 | |||||||||||
SYBASE (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Applecroft SL6 3HD Maidenhead 12 Berkshire United Kingdom |
| 160709230001 | ||||||||||
ACOSTA, Jack | Director | 60 Rosewood Lane Danville Califorbia 94506 Usa | American | Company Director | 63869700001 | |||||||||
ALBERS, Robert | Director | Schuttersweg 94 FOREIGN 1217 Rb Hilversum Netherlands | Dutch | Vice President European Operations | 28556600001 | |||||||||
BEESTON, Philip | Director | 14 Litton Court London Road Loudwater HP10 9RZ High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 39135060001 | ||||||||
BOWDEN, Terence Richard | Director | The Firs Wilkins Green Lane AL10 9RT Hatfield Hertfordshire | British | Finance Director | 68697000001 | |||||||||
BROEK, Cornelis | Director | P C Van Den Brintweg 14 1251 Pw Leren Netherlands | Dutch | Director | 79566600006 | |||||||||
BZIUK, Marco | Director | 253 Nordhorn Lingenerstrasse Lower Saxony 48531 Germany | German | Finance Director Ssc | 132422930001 | |||||||||
CARL, Daniel Robert | Director | 9 Hawkins Close RG12 2RF Bracknell Berkshire | American | Company Director | 65521800001 | |||||||||
CARRATT, David Jonathan | Director | 40 Illingworth St Leonards Hill SL4 4UP Windsor Berkshire | British | Information Systems Consultant | 22585710001 | |||||||||
CARRATT, David Jonathan | Director | 40 Illingworth St Leonards Hill SL4 4UP Windsor Berkshire | British | Information Systems Consultant | 22585710001 | |||||||||
COLE, Ian Roy | Director | 103 Wodeland Avenue GU2 4LD Guildford Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 79146730001 | ||||||||
DAVID, Peter | Director | Bedfont Road TW14 8HD Feltham Clockhouse Place Middlesex England | Germany | German | Chief Financial Officer, Emea | 203929760001 | ||||||||
DE GENNARO, Vincent | Director | 17 The Shires RG41 4SZ Wokingham Berkshire | British | Company Director | 71385120001 | |||||||||
DOEL, Robert Leslie | Director | Parkstone House Little Common Lane RH1 4QG Bletchingley Surrey | British | Accountant | 48149840001 | |||||||||
GIRAUDET DE BOUDEMANGE, Xavier Marie Jean Jacques | Director | 8 Allee St Gilles 92420 Vaucresson FOREIGN France | French | Company Director | 49019040001 | |||||||||
GREENWOOD, Mark | Director | Compass House Portsmouth Road GU30 7DJ Liphook Hampshire | United Kingdom | British | Engineer | 45286550001 | ||||||||
HEALY, Martin Joseph | Director | 706 Foothill Drive San Mateo California 94402 Usa | American | Vp & Corporate Controller | 87549790001 | |||||||||
HILLMAN, Julian David | Director | Bedfont Road TW14 8HD Feltham Clockhouse Place Middlesex England | England | British | Accountant | 87110220001 | ||||||||
HOFFMAN, Mark Bruce | Director | 3986 Paseo Grande Moraga California 94556 Usa | American | Company Director | 61365730001 | |||||||||
HOWGEGO, Christopher Alan Geoffrey | Director | Watercoombe Hambleden RG9 6SN Henley On Thames Oxon | United Kingdom | British | Computer Software | 96293160001 | ||||||||
HOWGEGO, Christopher Alan Geoffrey | Director | Watercoombe Hambleden RG9 6SN Henley On Thames Oxon | United Kingdom | British | Director | 96293160001 | ||||||||
JONES, Stephen Gareth | Director | 4 Peel Gardens Kingsclere RG15 8SB Newbury Berkshire | British | Accountant | 45714720001 | |||||||||
LOUTH, John Brian | Director | 6 Compton Way RG27 0SQ Sherfield On Loddon Hampshire | British | Company Director | 108893080001 |
¿Tiene SYBASE (UK) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deposit agreement and charge on cash deposits | Creado el 01 may 2002 Entregado el 03 may 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The sum of £1.000 deposited by the depositor at the banks offices at 250 bishopsgate london EC2M 4AA and all other sums from time to time standing to the credit of the depositor on any account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creado el 19 ago 1999 Entregado el 26 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rental deposit deed | Creado el 01 jul 1992 Entregado el 07 jul 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 4/7/92 | |
Breve descripción £19507.50. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 12 abr 1988 Entregado el 03 may 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0