SYBASE (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSYBASE (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02175260
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SYBASE (UK) LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra SYBASE (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sybase Court
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYBASE (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SYBASE SOFTWARE LIMITED08 oct 198708 oct 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SYBASE (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYBASE (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dissolve company 16/11/2016
    RES13

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Peter David como director el 02 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Julian David Hillman como director el 07 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Harald Winkler como director el 02 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jun 2016

    Estado de capital el 16 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Harald Winkler el 01 jun 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Christian Jehle el 01 jun 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Peter David el 01 jun 2016

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Julian David Hillman el 01 jun 2016

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Christian Jehle como director el 26 ene 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Peter David como director el 11 dic 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Elena Shishkina como director el 11 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2015

    Estado de capital el 15 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Helen Matthews como secretario el 24 dic 2014

    1 páginasTM02

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2013

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 jun 2014

    Estado de capital el 12 jun 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    319 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Estado de capital el 06 dic 2013

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    ¿Quiénes son los directivos de SYBASE (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JEHLE, Christian
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    Director
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    EnglandGermanChief Financial Officer Uk & Ireland204347190001
    BOWDEN, Terence Richard
    The Firs
    Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    Hertfordshire
    Secretario
    The Firs
    Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    Hertfordshire
    BritishFinance Director68697000001
    CARTER SHAW, Jonathan
    9 Clarefield Drive
    SL6 5DW Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    9 Clarefield Drive
    SL6 5DW Maidenhead
    Berkshire
    BritishSolicitor79566640004
    CARTER SHAW, Jonathan
    9 Clarefield Drive
    SL6 5DW Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    9 Clarefield Drive
    SL6 5DW Maidenhead
    Berkshire
    BritishSolicitor79566640004
    COLLET, Helle
    Flat No 7 5 Cornwall Gardens
    SW7 4AJ London
    St James' House
    Secretario
    Flat No 7 5 Cornwall Gardens
    SW7 4AJ London
    St James' House
    DanishSolicitor116344290003
    FORD, Sarah Ann
    Frenchmens Creek
    High Road
    SL6 9JS Cookham
    Berkshire
    Secretario
    Frenchmens Creek
    High Road
    SL6 9JS Cookham
    Berkshire
    British103703770001
    JONES, Stephen Gareth
    4 Peel Gardens
    Kingsclere
    RG15 8SB Newbury
    Berkshire
    Secretario
    4 Peel Gardens
    Kingsclere
    RG15 8SB Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant45714720001
    LEONARD, Philip
    Sybase Court
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Sybase Court
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Berkshire
    160771060001
    MATTHEWS, Helen
    Sybase Court
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Sybase Court
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Berkshire
    164142400001
    MOREY, Anthony Raymond
    Trefeddian
    Frimley Hall Drive
    GU15 2BE Camberley
    Surrey
    Secretario
    Trefeddian
    Frimley Hall Drive
    GU15 2BE Camberley
    Surrey
    BritishDirector32510520001
    WALTON, Nicholas David
    14 Shire Avenue
    GU51 2TB Fleet
    Hampshire
    Secretario
    14 Shire Avenue
    GU51 2TB Fleet
    Hampshire
    BritishChartered Accountant68048710001
    ROBINSON SERVICES LIMITED
    Howard House 70 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Secretario corporativo
    Howard House 70 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    7975740001
    SYBASE (UK) LIMITED
    Applecroft
    SL6 3HD Maidenhead
    12
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Applecroft
    SL6 3HD Maidenhead
    12
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2175260
    160709230001
    ACOSTA, Jack
    60 Rosewood Lane
    Danville
    Califorbia 94506
    Usa
    Director
    60 Rosewood Lane
    Danville
    Califorbia 94506
    Usa
    AmericanCompany Director63869700001
    ALBERS, Robert
    Schuttersweg 94
    FOREIGN 1217 Rb Hilversum
    Netherlands
    Director
    Schuttersweg 94
    FOREIGN 1217 Rb Hilversum
    Netherlands
    DutchVice President European Operations28556600001
    BEESTON, Philip
    14 Litton Court
    London Road Loudwater
    HP10 9RZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    14 Litton Court
    London Road Loudwater
    HP10 9RZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector39135060001
    BOWDEN, Terence Richard
    The Firs
    Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    The Firs
    Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    Hertfordshire
    BritishFinance Director68697000001
    BROEK, Cornelis
    P C Van Den Brintweg 14
    1251 Pw Leren
    Netherlands
    Director
    P C Van Den Brintweg 14
    1251 Pw Leren
    Netherlands
    DutchDirector79566600006
    BZIUK, Marco
    253
    Nordhorn
    Lingenerstrasse
    Lower Saxony 48531
    Germany
    Director
    253
    Nordhorn
    Lingenerstrasse
    Lower Saxony 48531
    Germany
    GermanFinance Director Ssc132422930001
    CARL, Daniel Robert
    9 Hawkins Close
    RG12 2RF Bracknell
    Berkshire
    Director
    9 Hawkins Close
    RG12 2RF Bracknell
    Berkshire
    AmericanCompany Director65521800001
    CARRATT, David Jonathan
    40 Illingworth
    St Leonards Hill
    SL4 4UP Windsor
    Berkshire
    Director
    40 Illingworth
    St Leonards Hill
    SL4 4UP Windsor
    Berkshire
    BritishInformation Systems Consultant22585710001
    CARRATT, David Jonathan
    40 Illingworth
    St Leonards Hill
    SL4 4UP Windsor
    Berkshire
    Director
    40 Illingworth
    St Leonards Hill
    SL4 4UP Windsor
    Berkshire
    BritishInformation Systems Consultant22585710001
    COLE, Ian Roy
    103 Wodeland Avenue
    GU2 4LD Guildford
    Surrey
    Director
    103 Wodeland Avenue
    GU2 4LD Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director79146730001
    DAVID, Peter
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    Director
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    GermanyGermanChief Financial Officer, Emea203929760001
    DE GENNARO, Vincent
    17 The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Director
    17 The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Director71385120001
    DOEL, Robert Leslie
    Parkstone House Little Common Lane
    RH1 4QG Bletchingley
    Surrey
    Director
    Parkstone House Little Common Lane
    RH1 4QG Bletchingley
    Surrey
    BritishAccountant48149840001
    GIRAUDET DE BOUDEMANGE, Xavier Marie Jean Jacques
    8 Allee St Gilles
    92420 Vaucresson
    FOREIGN France
    Director
    8 Allee St Gilles
    92420 Vaucresson
    FOREIGN France
    FrenchCompany Director49019040001
    GREENWOOD, Mark
    Compass House Portsmouth Road
    GU30 7DJ Liphook
    Hampshire
    Director
    Compass House Portsmouth Road
    GU30 7DJ Liphook
    Hampshire
    United KingdomBritishEngineer45286550001
    HEALY, Martin Joseph
    706 Foothill Drive
    San Mateo
    California 94402
    Usa
    Director
    706 Foothill Drive
    San Mateo
    California 94402
    Usa
    AmericanVp & Corporate Controller87549790001
    HILLMAN, Julian David
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    Director
    Bedfont Road
    TW14 8HD Feltham
    Clockhouse Place
    Middlesex
    England
    EnglandBritishAccountant87110220001
    HOFFMAN, Mark Bruce
    3986 Paseo Grande
    Moraga
    California 94556
    Usa
    Director
    3986 Paseo Grande
    Moraga
    California 94556
    Usa
    AmericanCompany Director61365730001
    HOWGEGO, Christopher Alan Geoffrey
    Watercoombe
    Hambleden
    RG9 6SN Henley On Thames
    Oxon
    Director
    Watercoombe
    Hambleden
    RG9 6SN Henley On Thames
    Oxon
    United KingdomBritishComputer Software96293160001
    HOWGEGO, Christopher Alan Geoffrey
    Watercoombe
    Hambleden
    RG9 6SN Henley On Thames
    Oxon
    Director
    Watercoombe
    Hambleden
    RG9 6SN Henley On Thames
    Oxon
    United KingdomBritishDirector96293160001
    JONES, Stephen Gareth
    4 Peel Gardens
    Kingsclere
    RG15 8SB Newbury
    Berkshire
    Director
    4 Peel Gardens
    Kingsclere
    RG15 8SB Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant45714720001
    LOUTH, John Brian
    6 Compton Way
    RG27 0SQ Sherfield On Loddon
    Hampshire
    Director
    6 Compton Way
    RG27 0SQ Sherfield On Loddon
    Hampshire
    BritishCompany Director108893080001

    ¿Tiene SYBASE (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deposit agreement and charge on cash deposits
    Creado el 01 may 2002
    Entregado el 03 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The sum of £1.000 deposited by the depositor at the banks offices at 250 bishopsgate london EC2M 4AA and all other sums from time to time standing to the credit of the depositor on any account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transacciones
    • 03 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 19 ago 1999
    Entregado el 26 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creado el 01 jul 1992
    Entregado el 07 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 4/7/92
    Breve descripción
    £19507.50.
    Personas con derecho
    • Lynton Properties Limited
    Transacciones
    • 07 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 abr 1988
    Entregado el 03 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 may 1988Registro de una carga
    • 17 abr 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0