SG LEASING XII

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSG LEASING XII
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02176172
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SG LEASING XII?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra SG LEASING XII?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SG LEASING XII?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SGLD LIMITED26 may 200026 may 2000
    SG LEASING (DECEMBER) LIMITED02 oct 199802 oct 1998
    HAMBROS LEASING (DECEMBER) LIMITED10 dic 198710 dic 1987
    HOLLYHOLD LIMITED09 oct 198709 oct 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SG LEASING XII?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SG LEASING XII?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ago 2017

    6 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ago 2016

    4 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG a 15 Canada Square London E14 5GL el 21 ago 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 ago 2015

    LRESSP

    Cese del nombramiento de David Coxon como director el 10 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Alexander Nimmo como director el 10 ago 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 oct 2014

    Estado de capital el 16 oct 2014

    • Capital: GBP 151,352
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    29 páginasAA

    Registro de la carga 021761720007

    17 páginasMR01

    Registro de la carga 021761720008

    17 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 oct 2013

    Estado de capital el 15 oct 2013

    • Capital: GBP 151,352
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG* el 15 oct 2013

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    31 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gareth Williams como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    28 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SG LEASING XII?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine ('Kasia') Marie Madeleine
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    British65878370001
    DENT, Nicholas Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishChartered Accountant43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishBanker135237620001
    BOWRING, Ian Stuart
    28 Gatcombe Mews
    Ealing Common
    W5 3HF London
    Secretario
    28 Gatcombe Mews
    Ealing Common
    W5 3HF London
    British52117360002
    CAMERON, Marion Rose
    The Old Cottage
    31 The Village
    HP5 1TZ Latimar
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Old Cottage
    31 The Village
    HP5 1TZ Latimar
    Buckinghamshire
    British2857840001
    NIMMO, Mark Alexander
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    Secretario
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    BritishSolicitor33420600001
    O'CONNOR, Maureen
    7 Cleveland Square
    W2 6DH London
    Secretario
    7 Cleveland Square
    W2 6DH London
    British14683810003
    THOMAS, Kerry Anne Abigail
    25a Danby Street
    East Dulwich
    SE15 4BS London
    Secretario
    25a Danby Street
    East Dulwich
    SE15 4BS London
    British61457700001
    BISHOP, Julian Kenneth, Mr.
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    Director
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant20351210002
    CHANDLER, Stuart Rodwell
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    Director
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    BritishExecutive Director59605380001
    COXON, David
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Director
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker121539300001
    CURTIN, Anthony Gerard
    42a Monkhams Drive
    IG8 0LE Woodford Green
    Essex
    Director
    42a Monkhams Drive
    IG8 0LE Woodford Green
    Essex
    Australian/BritishBanker34944920003
    DUFFY, Paul James
    48 Sauncey Avenue
    AL5 4QL Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    48 Sauncey Avenue
    AL5 4QL Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBanker2009170002
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant113760650001
    GAVAGHAN, David Nicholas
    11 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    Director
    11 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    BritishBanker47950870001
    HASTINGS, Christopher Alan
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    Director
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    United KingdomBritishInvestment Banker68475890001
    LOMBARDO, Guido Giulio Fortunato
    Flat 7
    47 Bramham Gardens
    SW5 0HG London
    Director
    Flat 7
    47 Bramham Gardens
    SW5 0HG London
    AtalianBanker34599420001
    MALLIN, Anthony Granville
    29 Highbury Hill
    N5 1SU London
    Director
    29 Highbury Hill
    N5 1SU London
    United KingdomBritishBanker23460170001
    MEAGHER, Patrick Joseph
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishInvestment Banker62293450003
    MESNIL, Marc Rene
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    Director
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    FranceInvestment Banker75589840001
    MUNRO, Alan William Webster
    4 Staceys Meadow
    Elstead
    GU8 6BX Godalming
    Surrey
    Director
    4 Staceys Meadow
    Elstead
    GU8 6BX Godalming
    Surrey
    BritishBanker1636910002
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Director
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor33420600001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Director
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    STEWART, James Alexander Gustave Harold
    Lundsford House
    Lundsford Farm
    TN19 7QH Etchingham
    East Sussex
    Director
    Lundsford House
    Lundsford Farm
    TN19 7QH Etchingham
    East Sussex
    BritishBanker72563010001
    TAYLOR, Paul Richard
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    Director
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    BritishInvestment Banker75085060001
    VOLKERS, Niek
    33 Koperwiekweg
    3403 ZT Ijsselstein
    Netherlands
    Director
    33 Koperwiekweg
    3403 ZT Ijsselstein
    Netherlands
    NetherlandsDutchBanker122228040001
    WALKER, John Dallow
    27 Thurleigh Road
    SW12 8UB London
    Director
    27 Thurleigh Road
    SW12 8UB London
    BritishCompany Director38763500002
    WILLIAMS, Gareth, Mr.
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    Director
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United KingdomBritishBanker120326750001

    ¿Tiene SG LEASING XII alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 dic 2013
    Entregado el 06 ene 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 06 ene 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 23 dic 2013
    Entregado el 06 ene 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 06 ene 2014Registro de una carga (MR01)
    Sub intermediate lessor assignment with respect to M.T. bow cecil
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 29 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any of the relevant parties to any one or more of sg the head intermediate lessor, the company, the chargee and dsb under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights and interests of every kind which the company now or at any later time has to or in: the intermediate lease agreement between the head intermediate lessor and the company dated 13 june 2007;. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale Acting Through Its London Branch
    Transacciones
    • 29 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Sub intermediate lessor assignment with respect to M.T. bow cardinal
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 29 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any of the relevant parties to any one or more of sg the head intermediate lessor, the company, the chargee and dsb under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights and interests of every kind which the company now or at any later time has to or in: the intermediate lease agreement between the head intermediate lessor and the company dated 13 june 2007;. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale Acting Through Its London Branch
    Transacciones
    • 29 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over cash deposit and account and deed of assignment
    Creado el 25 jun 2003
    Entregado el 01 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £14,888,955.70 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all monies standing to the credit of the dedicated account. By way of security all of its right title and interest in and to the benefit of the leasing agreement in respect of the feature film entitled "jason and the argonauts" and the benefit of the guarantee dated 30/03/2000.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 01 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash deposit and account and deed of assignment
    Creado el 25 jun 2003
    Entregado el 01 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £11,412,743.82 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge all monies standing to the credit of the dedicated account. By way of security all of its right title and interest in and to the benefit of the leasing agreement in respect of the feature film "the magical legend of the leprechauns" and the benefit of the guarantee dated 04/11/1999.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 01 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash deposit and account and deed of assignment
    Creado el 06 nov 2002
    Entregado el 11 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £25,424,222.79 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the account in the name of the chagor at the bank sort code 23-63-91 account number 03801918 account description sg leasing (december) limited together with all entitlements to interest the right to repayment and other rights and benefits accruing thereto or arising in connection therewith. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale
    Transacciones
    • 11 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Creado el 14 nov 1995
    Entregado el 17 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a loan agreement dated 14TH november 1995 (as the same may from time to time hereafter be amended, varied or supplemented)
    Breve descripción
    64TH/64TH shares of and in the M.V. "alkmini" and in her boats, guns, ammunition and under official number 727477.
    Personas con derecho
    • Hambros Bank Limited
    Transacciones
    • 17 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SG LEASING XII algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 ago 2018Fecha de disolución
    11 ago 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0