RYSBRIDGE ESTATES LIMITED

RYSBRIDGE ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRYSBRIDGE ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02178607
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PORTRENT LIMITED14 oct 198714 oct 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    39 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 abr 2017

    28 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 abr 2016

    31 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 abr 2015

    33 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 abr 2014

    33 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de 179 Great Portland Street London W1W 5LS el 22 abr 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cese del nombramiento de un director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicolae Christopher Ratiu como director el 14 feb 2013

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr William Robert Starn como director el 14 mar 2013

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jagtar Singh como director el 08 may 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Gary Balfour-Lynn como director el 31 mar 2012

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 dic 2011

    Estado de capital el 13 dic 2011

    • Capital: GBP 4,400
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2010 au 30 jun 2011

    3 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    Misceláneos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Blurton como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    21 páginasAR01

    Cambio de datos del director Andrew Francis Blurton el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CITY GROUP PLC
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    Secretario corporativo
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    35794270004
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secretario corporativo
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    KARMEL, Simon Harry
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    Director
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    EnglandBritish2014130001
    STARN, William Robert
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican154007330001
    LIPSCOMB, Helen
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    Secretario
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    British5036040002
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Secretario
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    WOOLLEY, Roderic Harry
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    Secretario
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    British1017530003
    ARTUS, Alan Norman
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    Director
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    British72061440002
    AUSTEN, Jonathan Martin
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    Director
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    British36694850001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Director
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    BOWES, Graham
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    Director
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    British37707190003
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Director
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    INGMAN, Philip Michael
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    Director
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    British54153030001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Director
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    PLUMMER, Jeremy James
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    Director
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    EnglandBritish3994380002
    POPE, Nigel Howard
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    Director
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    British29583660001
    RATIU, Nicolae Christopher
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    Director
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    United KingdomBritish67475010001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Director
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    Director
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    British39476870001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Director
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SLOAN, Roderick David Gray
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    Director
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    British9739700002
    STEVENS, Michael
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    British60348780001
    TIPPING, Geoffrey Nigel
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    Director
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    United KingdomBritish80925340001
    WALSH, David George Patrick
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    Director
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    British11107290001

    ¿Tiene RYSBRIDGE ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 04 jul 2000
    Entregado el 10 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and any other company named therein to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge all right title and interest in each of the assets: real property, bank accounts, insurances, benefit of licenses consents and authorisations. Floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 10 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 abr 2000
    Entregado el 21 abr 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All liabilities of the obligors owed or expressed to be owed to the charge (the agent) and to the beneficiaries under or in connection with the finance documents inclcuding principal interest fees costs and expenses and whether owed jointly or severally as principal or surety or in any othr capacity
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bhf-Bank Ag
    Transacciones
    • 21 abr 2000Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 25 mar 1998
    Entregado el 27 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for iself and the banks as defined) under the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    All real property,any investment,goodwill and uncalled capital,money standing to the credit of any designated account for full details of all charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bhf-Bank Ag
    Transacciones
    • 27 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 25 jun 1990
    Entregado el 03 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Breve descripción
    Naval row blackwall way, tower markets, l/b of tower hamlets title no egl 200588 and/or the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1990Registro de una carga
    • 11 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 25 jun 1990
    Entregado el 03 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Breve descripción
    Kensington village avon trading estate aranmore road, l/b of hammersmith & fulham title no ngl 621514 and/or the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1990Registro de una carga
    • 11 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 sept 1988
    Entregado el 27 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 sept 1988Registro de una carga
    • 22 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 dic 1987
    Entregado el 17 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property k/a land & buildings on the south side of navalrow and on the east side of blackwall way, london E14, title no. Egl 200588.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 1987Registro de una carga
    • 22 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 dic 1987
    Entregado el 17 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property k/a avon trading estate situate at avonmore road fulham, title no. Ngl 125133.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 1987Registro de una carga
    • 22 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene RYSBRIDGE ESTATES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 abr 2013Inicio de la liquidación
    29 jun 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0