AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02184473 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Dirección de la sede social | New Globe House Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
DIALSENIOR LIMITED | 28 oct 1987 | 28 oct 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 19 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Comptes annuels modifiés établis au 30 sept 2022 | 26 páginas | AAMD | ||||||||||
Nombramiento de Antoine Erwan Creau como director el 21 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Sophie Elisabeth Croft como director el 21 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sdl Limited como director el 21 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Rws Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 may 2024 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Sdl Global Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 may 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Gary Peter William Hall como director el 17 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Mark Storey como director el 17 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2022 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Mark Storey como director el 13 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominique Francois Lionnel Lalli como director el 13 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dominique Francois Lionnel Lalli como director el 14 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Mark Everitt como director el 14 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 80 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREAU, Antoine Erwan | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | French | Finance Director | 323892570001 | ||||||||
CROFT, Sophie Elisabeth | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | British | Finance Director | 291483680001 | ||||||||
HALL, Gary Peter William | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | British | Group Financial Controller | 308452900001 | ||||||||
ADAMS, John William | Secretario | 3 The Green Woodshaw SN4 8ND Wootton Bassett Wiltshire | British | 82377330001 | ||||||||||
HARRADENCE, Michael Edward | Secretario | 24 Camelia Way RG41 3NB Wokingham | British | Financial Controller | 71887770001 | |||||||||
MARSHALL, David John | Secretario | 119 Saint James Road SK4 4RE Stockport Cheshire | British | Company Director | 14142080002 | |||||||||
RIDDLE, Gordon Henry | Secretario | 12 Banberry Drive Wombourne WV5 0AH Wolverhampton West Midlands | British | 55039990001 | ||||||||||
ADAMS, John William | Director | 3 The Green Woodshaw SN4 8ND Wootton Bassett Wiltshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 82377330001 | ||||||||
BRIDGMAN, Joanne Elizabeth | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Director | 157509990001 | ||||||||
BRIDGMAN, Joanne Elizabeth | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Director | 157509990001 | ||||||||
BUCKINGHAM, Andrew Nicholas | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | England | British | Accountant | 108509150002 | ||||||||
CANT, Robert | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | British | Accountant | 261902490001 | ||||||||
COKER, Christopher | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | British | Director | 186437190001 | ||||||||
EVERITT, Timothy Mark | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | United Kingdom | British | Company Director | 269344620002 | ||||||||
GORDON, Alastair Neil | Director | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | Accountant | 61620710001 | ||||||||
GRANT, Mark | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | England | British | Director | 187711010001 | ||||||||
HARRADENCE, Michael Edward | Director | 24 Camelia Way RG41 3NB Wokingham | British | Financial Controller | 71887770001 | |||||||||
HARRIS, Paul Alan | Director | 20 Cherington Close Matchborough East B98 0BB Redditch Worcestershire | British | Accountant | 27135170001 | |||||||||
HUNTER, John | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Director | 205528410001 | ||||||||
KNIGHT, Matthew | Director | Globe House Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Berkshire | England | British | Director | 159703240001 | ||||||||
LALLI, Dominique Francois Lionnel | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | United Kingdom | Italian | Emea Regional Financial Controller | 293003520001 | ||||||||
MARSHALL, David John | Director | 119 Saint James Road SK4 4RE Stockport Cheshire | British | Company Director | 14142080002 | |||||||||
MCFARLANE, Iain | Director | Avenue Farm GL7 6EG Poole Keynes Gloucestershire | British | Accountant | 118934440001 | |||||||||
RIDDLE, Gordon Henry | Director | 12 Banberry Drive Wombourne WV5 0AH Wolverhampton West Midlands | British | Company Director | 55039990001 | |||||||||
SEAL, Thomas Frank | Director | 4510 County Lane Road Salt Lake City Utah Ut84117 FOREIGN Usa | American | Company Director | 51332970001 | |||||||||
STOREY, Christopher Mark | Director | Vanwall Business Park Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England | England | British | Group Financial Controller | 104266220002 | ||||||||
WITTWER, John William | Director | 2144 Marwood Circle FOREIGN Salt Lake City Utah Ut84124 Usa | American | Company Director | 12500110001 | |||||||||
SDL LIMITED | Director corporativo | Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead New Globe House England |
| 182117900005 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AUTOMATED LANGUAGE PROCESSING SERVICES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rws Holdings Plc | 05 may 2024 | Chiltern Hill SL9 9FG Chalfont St. Peter Europa House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Sdl Global Holdings Limited | 06 abr 2016 | Clivemont Road SL6 7DY Maidenhead Sdl, Globe House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0