WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02190074 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
- Actividades de consultoría científica y técnica relacionada con la ingeniería (71122) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades de ingeniería (71129) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Actividades de consultoría ambiental (74901) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Wsp House 70 Chancery Lane WC2A 1AF London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WOOD ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED | 16 abr 2018 | 16 abr 2018 |
| AMEC FOSTER WHEELER ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE UK LIMITED | 19 dic 2014 | 19 dic 2014 |
| AMEC ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE UK LIMITED | 27 jun 2011 | 27 jun 2011 |
| ENTEC UK LIMITED | 13 feb 1995 | 13 feb 1995 |
| THE WATER SHOP LIMITED | 12 ene 1988 | 12 ene 1988 |
| COVENTINA LIMITED | 09 nov 1987 | 09 nov 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Hannah Frances Pilsworth como secretario el 06 mar 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Anne Sewell como secretario el 06 mar 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Reilly como director el 16 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark William Naysmith como director el 16 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 18 nov 2024
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2024 au 31 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Edward Llewellyn Humphries como director el 18 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2022 au 30 jun 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 6 Devonshire Square London EC2M 4YE | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 6 Devonshire Square London EC2M 4YE | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Samuel Ian Cromie como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Karen Anne Sewell como secretario el 21 sept 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Notification de Wsp European Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 sept 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Amec Foster Wheeler Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 sept 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILSWORTH, Hannah Frances | Secretario | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | 333308990001 | |||||||
| BARNARD, Miles Lawrence | Director | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | England | British | 258728110001 | |||||
| REILLY, Paul | Director | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | England | British | 67639350003 | |||||
| BROWN, Clare | Secretario | 6 Silkwood Close Northburn Lea NE23 9LS Cramlington Northumberland | British | 44602140001 | ||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Secretario | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire England | 150839610001 | |||||||
| JONES, Iain Angus | Secretario | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | 243963710001 | |||||||
| OLIVER, Sandra Lilian | Secretario | 24 Cairn Park Longframlington NE65 8JS Morpeth Northumberland | British | 39117990002 | ||||||
| PARKER, Martin | Secretario | 37 Lindisfarne Close Jesmond NE2 2HT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 18784420004 | ||||||
| PARKER, Martin | Secretario | 37 Lindisfarne Close Jesmond NE2 2HT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 18784420004 | ||||||
| SEWELL, Karen Anne | Secretario | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | 300351870001 | |||||||
| WARBURTON, Jennifer Ann | Secretario | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | 210977180001 | |||||||
| WATSON, David John | Secretario | 13 Apperley Avenue High Shincliffe DH1 2TY Durham | British | 14035170001 | ||||||
| ARMES-REARDON, Simon Patrick John Francis | Director | Regent Centre Gosforth NE3 3PX Newcastle Upon Tyne Northumbria House Tyne & Wear England | United Kingdom | British | 42227660003 | |||||
| BAFNA, Tarun | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | Usa | American | 150860790001 | |||||
| BARROW, Deborah | Director | Lakewood Parkway Suite 300 Alpharetta 1105 Georgia 30009 United States | United States | American | 240968530001 | |||||
| BOURNE, Philip Henry | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | United Kingdom | British | 161714770002 | |||||
| BROWN, Clare | Director | 6 Silkwood Close Northburn Lea NE23 9LS Cramlington Northumberland | British | 44602140001 | ||||||
| BROWN, Robert Philip | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | Scotland | British | 181491820001 | |||||
| CANFIELD, Barry | Director | Regent Centre Gosforth NE3 3PX Newcastle Upon Tyne Northumbria House Tyne & Wear England | England | British | 70076020001 | |||||
| CLARKE, John James | Director | Manor Close KT24 6SB East Horsley Dalehurst Surrey England | United Kingdom | British | 150891000001 | |||||
| CROMIE, Samuel Ian | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | England | British | 246655780001 | |||||
| CUTHBERT, John Arthur | Director | 9 Larwood Court DH3 3QQ Chester Le Street Durham | United Kingdom | British | 55227570001 | |||||
| FARMAN, Christopher | Director | Brook House 1 Willowgarth Hutton Rudby TS15 0LE Yarm Cleveland | British | 12040780002 | ||||||
| FLEMING, Colin Ross | Director | Rubislaw Den North AB15 4AN Aberdeen 12 Scotland | Scotland | British | 72033550002 | |||||
| FOSTER, John Anthony | Director | 8 Burnside Close Ovingham NE42 6BS Prudhoe Northumberland | British | 30561030001 | ||||||
| GREEN, Christopher Michael | Director | South View House North Bank NE47 6LU Haydon Bridge Northumberland | United Kingdom | British | 25577780001 | |||||
| HUMPHRIES, Charles Edward Llewellyn | Director | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | England | British | 280140410001 | |||||
| JINKS, Anthony Roger | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | Usa | British Canadian | 150858850001 | |||||
| LUCK, Chris, Dr | Director | Long Gable 21 Bois Avenue Chesham Bow HP6 5NU Amersham Bucks | British | 29567420001 | ||||||
| MAHMOUD, Hisham Helmi Hussein, Dr | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | Usa | American | 157504920001 | |||||
| MAYBERRY, Brian Richard | Director | Glencairn Glen Road FK15 0DJ Dunblane Stirlingshire | British | 43371460002 | ||||||
| MCLAREN, Richard Andrew | Director | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | United Kingdom | British | 161719330001 | |||||
| MENON, David Alexander | Director | Wood Lane Timperley WA15 7QG Altrincham 11 Cheshire England | England | British | 70076630002 | |||||
| MOORE, Elaine | Director | 28 John Street WC1N 2BL London Flat 7 England | United Kingdom | American | 150837820001 | |||||
| MORTON, Diane | Director | Moorland Slaley NE47 0BP Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 62515500003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WSP ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsp European Holdings Limited | 21 sept 2022 | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Amec Foster Wheeler Limited | 25 nov 2019 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Entec Holdings Limited | 06 sept 2018 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Entec Investments Limited | 06 abr 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0