MALAIKA4 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMALAIKA4 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02190848
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MALAIKA4 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MALAIKA4 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MALAIKA4 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WIPAC GROUP LIMITED26 jul 198826 jul 1988
    CALLRESERVE LIMITED10 nov 198710 nov 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MALAIKA4 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MALAIKA4 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MALAIKA4 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    GAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2013

    6 páginasAA

    Estado de capital el 30 abr 2014

    • Capital: GBP 0.004
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2012

    6 páginasAA

    Nombramiento de Graham Middlemiss como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Graham Middlemiss como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tom Brophy como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Tom Brophy como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Alison Drew como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2010

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert Andrew Ross Smith como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2009

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Stephen Paul Webster el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de MALAIKA4 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIDDLEMISS, Graham
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    Secretario
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    174237020001
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Director
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritish150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Director corporativo
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BROPHY, Tom
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    162242400001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Secretario
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    British43046230002
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    British86703050001
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Secretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    Secretario
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    British53281480001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BROWN, Alan James
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    Director
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    United KingdomBritish124294280002
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Director
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    British43046230002
    BUTLER, Alan Frederick
    Cotswold House 5a Southlands
    Aston
    OX18 2DA Bampton
    Oxfordshire
    Director
    Cotswold House 5a Southlands
    Aston
    OX18 2DA Bampton
    Oxfordshire
    British39813510001
    EARL, Geoffrey James
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    Director
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    United KingdomBritish86673550001
    FERRIS, William Cyril
    2 Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    Worcestershire
    Director
    2 Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    Worcestershire
    British1210060001
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Director
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish86703050001
    JONES, Keith
    13 Hunt Close
    OX6 7HX Bicester
    Oxon
    Director
    13 Hunt Close
    OX6 7HX Bicester
    Oxon
    British45399990002
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    Director
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    British67271850002
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    MASTERS, Alexander Frank
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British9424220001
    MONK, Brian
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    British19699310001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Director
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    PEDERSEN, Alan Nicholson Val
    29 Queen Street
    HP20 1LU Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    29 Queen Street
    HP20 1LU Aylesbury
    Buckinghamshire
    British22165640001
    ROBERTSON-SMITH, Michael John
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    Director
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish85369940001
    SHEPHERD, David Nigel
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    Director
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    British40976920001
    SOUTHAM, Ivor Kenneth
    39 Galsworthy Place
    HP19 3LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    39 Galsworthy Place
    HP19 3LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60815430001
    STERNE, Dermot Desmond
    24 North End Square
    MK18 1NX Buckingham
    Director
    24 North End Square
    MK18 1NX Buckingham
    British45376070002
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    Director
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    GbBritish53281480001
    WANSBROUGH, David George Rawdon
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    Director
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    British47849990001
    WARD, Malcolm Stuart
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    British35014310003
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Director
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritish40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Director
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritish82978250002

    ¿Tiene MALAIKA4 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 31 mar 1993
    Entregado el 08 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Eci Developments
    Transacciones
    • 08 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 feb 1991
    Entregado el 01 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and the holders of the loan notes (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge, all the company's present and future undertaking and assets, whatsoever and wherever including its uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Royal Trust Company of Canada Limited
    Transacciones
    • 01 mar 1991Registro de una carga
    • 07 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 04 dic 1989
    Entregado el 14 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 dic 1989Registro de una carga
    • 08 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 nov 1989
    Entregado el 29 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1989Registro de una carga
    • 08 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0