OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED

OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02196366
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Studio Building
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MONEYDAWN LIMITED19 nov 198719 nov 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Sarabjit Singh Birdi como director el 22 ene 2015

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lewis John Pepall como director el 01 abr 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Paul Chamberlain como director el 01 abr 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Sarabjit Singh Birdi como director el 01 abr 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Miss Theriza Domingo como secretario el 01 abr 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Jean Llewellyn Evans como secretario el 01 abr 2014

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 nov 2013

    Estado de capital el 20 nov 2013

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard Jean Llewellyn Evans como secretario el 31 may 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Charles como secretario el 31 may 2013

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    23 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Whitefriars Avenue Harrow Middlesex HA3 5RH el 05 ene 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    23 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael Charles como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Lewis John Pepall como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Janet Keightley como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Janet Keightley como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Robson como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 26 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DOMINGO, Theriza
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    Secretario
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    187219610001
    WOODWARD, Paul
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    Director
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish149576820001
    BAGNALL, Christopher
    Coppice Bank Cottage
    Ranters Bank Far Forest
    DY14 9DT Rock Nr Kidderminster
    Worcs
    Secretario
    Coppice Bank Cottage
    Ranters Bank Far Forest
    DY14 9DT Rock Nr Kidderminster
    Worcs
    British19513450001
    CHARLES, Michael
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    Secretario
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    161096440001
    EVANS, Richard Jean Llewellyn
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    Secretario
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    179094360001
    KEIGHTLEY, Janet Rosalyn
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    Secretario
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    British38842780002
    WALKER, Michael Frederick
    88 Westminster Way
    OX2 0LP Oxford
    Oxfordshire
    Secretario
    88 Westminster Way
    OX2 0LP Oxford
    Oxfordshire
    British15156470001
    ASTON, Paul
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    Director
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    EnglandBritish68449490002
    BAGNALL, Christopher
    Coppice Bank Cottage
    Ranters Bank Far Forest
    DY14 9DT Rock Nr Kidderminster
    Worcs
    Director
    Coppice Bank Cottage
    Ranters Bank Far Forest
    DY14 9DT Rock Nr Kidderminster
    Worcs
    British19513450001
    BIRDI, Sarabjit Singh
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    Director
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    EnglandBritish187180370001
    CHAMBERLAIN, Steven Paul
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    Director
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish149576580001
    GOODBAN, Richard
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    Director
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    United KingdomBritish118232240001
    HENDERSON, Michael William George
    Hydon Barn
    Upper Vann Lane
    GU8 4ED Hambledon
    Surrey
    Director
    Hydon Barn
    Upper Vann Lane
    GU8 4ED Hambledon
    Surrey
    United KingdomBritish65172990001
    KEIGHTLEY, Janet Rosalyn
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    Director
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    United KingdomBritish38842780002
    PEPALL, Lewis John
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    Director
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    The Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish161095610001
    ROBSON, Neil
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    Director
    Whitefriars Avenue
    Harrow
    HA3 5RH Middlesex
    EnglandBritish114388150001
    URNES, Erik
    Bengt Langhs Gata
    25433 Helsingborg
    13
    Sweden
    Director
    Bengt Langhs Gata
    25433 Helsingborg
    13
    Sweden
    Norwegian117661600002
    WRAIGHT, Christopher Edward
    9 Aston Park
    Aston Rowant
    OX49 5SW Watlington
    Oxfordshire
    Director
    9 Aston Park
    Aston Rowant
    OX49 5SW Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish16035300005
    YEOMANS, John Frank
    Little Mead Broome Lane
    Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    Little Mead Broome Lane
    Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomEnglish17114850002

    ¿Tiene OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 11 ago 1999
    Entregado el 20 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each or any of the senior finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Merita Bank PLC,as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 20 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 05 nov 1997
    Entregado el 07 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge over all assets now or hereinafter acquired by the chargeor in which it now has or acquires in the future and interest and all leasing hire purchase contract hire or similar agreements by way of floating charge all new motor vehicles used motor vehicles spare parts and all other assets acquired by the chargeor for the purpose of resale and all leasing contract hire hire purchase or similar agreements and all other assets of the chargeor.
    Personas con derecho
    • Associated Credits Limited
    Transacciones
    • 07 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 abr 1989
    Entregado el 05 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 17 lisle avenue kidderminster and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1989Registro de una carga
    • 15 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 12 ene 1989
    Entregado el 19 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ene 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0