OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02196366 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Studio Building 21 Evesham Street W11 4AJ London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MONEYDAWN LIMITED | 19 nov 1987 | 19 nov 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarabjit Singh Birdi como director el 22 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lewis John Pepall como director el 01 abr 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Paul Chamberlain como director el 01 abr 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sarabjit Singh Birdi como director el 01 abr 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Theriza Domingo como secretario el 01 abr 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Jean Llewellyn Evans como secretario el 01 abr 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Jean Llewellyn Evans como secretario el 31 may 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Charles como secretario el 31 may 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Whitefriars Avenue Harrow Middlesex HA3 5RH el 05 ene 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Charles como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Lewis John Pepall como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Janet Keightley como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Janet Keightley como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Robson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO, Theriza | Secretario | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building | 187219610001 | |||||||
| WOODWARD, Paul | Director | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building United Kingdom | United Kingdom | British | 149576820001 | |||||
| BAGNALL, Christopher | Secretario | Coppice Bank Cottage Ranters Bank Far Forest DY14 9DT Rock Nr Kidderminster Worcs | British | 19513450001 | ||||||
| CHARLES, Michael | Secretario | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building United Kingdom | 161096440001 | |||||||
| EVANS, Richard Jean Llewellyn | Secretario | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building United Kingdom | 179094360001 | |||||||
| KEIGHTLEY, Janet Rosalyn | Secretario | Whitefriars Avenue Harrow HA3 5RH Middlesex | British | 38842780002 | ||||||
| WALKER, Michael Frederick | Secretario | 88 Westminster Way OX2 0LP Oxford Oxfordshire | British | 15156470001 | ||||||
| ASTON, Paul | Director | Whitefriars Avenue Harrow HA3 5RH Middlesex | England | British | 68449490002 | |||||
| BAGNALL, Christopher | Director | Coppice Bank Cottage Ranters Bank Far Forest DY14 9DT Rock Nr Kidderminster Worcs | British | 19513450001 | ||||||
| BIRDI, Sarabjit Singh | Director | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building | England | British | 187180370001 | |||||
| CHAMBERLAIN, Steven Paul | Director | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building United Kingdom | United Kingdom | British | 149576580001 | |||||
| GOODBAN, Richard | Director | Whitefriars Avenue Harrow HA3 5RH Middlesex | United Kingdom | British | 118232240001 | |||||
| HENDERSON, Michael William George | Director | Hydon Barn Upper Vann Lane GU8 4ED Hambledon Surrey | United Kingdom | British | 65172990001 | |||||
| KEIGHTLEY, Janet Rosalyn | Director | Whitefriars Avenue Harrow HA3 5RH Middlesex | United Kingdom | British | 38842780002 | |||||
| PEPALL, Lewis John | Director | 21 Evesham Street W11 4AJ London The Studio Building United Kingdom | United Kingdom | British | 161095610001 | |||||
| ROBSON, Neil | Director | Whitefriars Avenue Harrow HA3 5RH Middlesex | England | British | 114388150001 | |||||
| URNES, Erik | Director | Bengt Langhs Gata 25433 Helsingborg 13 Sweden | Norwegian | 117661600002 | ||||||
| WRAIGHT, Christopher Edward | Director | 9 Aston Park Aston Rowant OX49 5SW Watlington Oxfordshire | England | British | 16035300005 | |||||
| YEOMANS, John Frank | Director | Little Mead Broome Lane Blakedown DY10 3LP Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | English | 17114850002 |
¿Tiene OASIS ART & CRAFT PRODUCTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 11 ago 1999 Entregado el 20 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each or any of the senior finance documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 05 nov 1997 Entregado el 07 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed charge over all assets now or hereinafter acquired by the chargeor in which it now has or acquires in the future and interest and all leasing hire purchase contract hire or similar agreements by way of floating charge all new motor vehicles used motor vehicles spare parts and all other assets acquired by the chargeor for the purpose of resale and all leasing contract hire hire purchase or similar agreements and all other assets of the chargeor. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 14 abr 1989 Entregado el 05 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 17 lisle avenue kidderminster and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 12 ene 1989 Entregado el 19 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0