TIBC LTD
Visión general
Nombre de la empresa | TIBC LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Liquidación |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02196824 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TIBC LTD?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra TIBC LTD?
Dirección de la sede social | 5th Floor, Grove House 248a Marylebone Road NW1 6BB London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIBC LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
THE IMPERIAL BATHROOM COMPANY LIMITED | 11 dic 2002 | 11 dic 2002 |
THE IMPERIAL BATHROOM COMPANY PLC | 01 abr 1991 | 01 abr 1991 |
MASTER MODEL CERAMIC SERVICES LIMITED | 28 ene 1988 | 28 ene 1988 |
LIFTCHIEF LIMITED | 20 nov 1987 | 20 nov 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TIBC LTD?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 29 sept 2021 |
Próximas cuentas vencen el | 29 jun 2022 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2020 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TIBC LTD?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 abr 2023 |
Próxima declaración de confirmación vence | 28 abr 2023 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 abr 2022 |
Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIBC LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2024 | 15 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 24 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2023 | 15 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Robert Stevenson como director el 27 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2022 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 abr 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road Aldridge West Midlands WS9 8XT a 5th Floor, Grove House 248a Marylebone Road London NW1 6BB el 01 nov 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de asuntos | 8 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2020 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 abr 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Neil Bucktrout como director el 30 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John David Kitchiner como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Charles Lousada como director el 01 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Wright como director el 16 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Registro de la carga 021968240007, creada el 04 nov 2020 | 38 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graham Neil Bucktrout como director el 23 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 mar 2020 au 29 sept 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Charles Lousada como director el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Kitchiner como director el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Robin Wright el 07 jul 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director James Robert Stevenson el 07 jul 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TIBC LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIN, Ian | Secretario | 9 Charnwood Close WS15 2SU Rugeley Staffordshire | British | Chartered Accountant | 69463390001 | |||||
FERRIDAY, David Ian | Secretario | 14 St Agathas Close Dothill TF1 3QP Telford Shropshire | British | 39985030002 | ||||||
GORE, Neil | Secretario | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | 156047710001 | |||||||
GORE, Neil | Secretario | 5 Edward Road Mere Green Sutton Coldfield West Midlands | British | Director | 26988540001 | |||||
HALLIWELL, Peter Frank | Secretario | Park Gate House 1 Warrington Road Mere WA16 0TE Knutsford Cheshire | British | 35520380001 | ||||||
LEARY, David James | Secretario | 6 Cambridge Avenue Wylde Green B73 5NA Sutton Coldfield West Midlands | British | Accountant | 74092310001 | |||||
RUSSELL, Michael Charles | Secretario | 43 Gilpin Crescent WS3 4HR Walsall West Midlands | British | 66921760001 | ||||||
WOOLDRIDGE, David Robert | Secretario | 96 Whetstone Lane WS9 0EU Aldridge West Midlands | British | 124865280001 | ||||||
ALFORD, Lawrence Stanley Keith | Director | Burford House Croftfields CV23 8LR Napton Warwickshire | British | Director | 47209750002 | |||||
BUCKTROUT, Graham Neil | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | England | British | Director | 158090090003 | ||||
BUCKTROUT, Graham Neil | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | England | British | Sales Director | 158090090001 | ||||
COLE, Graham Robert | Director | Appin Peggys Walk Littlebury CB11 4TG Saffron Walden Essex | British | Managing Director | 43213710001 | |||||
GARRIDO, Antonio | Director | The Willows 30 Moseley Road Cheadle Hulme SK8 5HJ Stockport Cheshire | British | Managing Director | 102777480001 | |||||
GILL, John James | Director | 27 Kinloch Drive DY1 3DB Dudley West Midlands | England | British | Sales Director | 105128850002 | ||||
GORE, Neil | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | United Kingdom | British | Financial Director | 87747750002 | ||||
HALLIWELL, Peter Frank | Director | Park Gate House 1 Warrington Road Mere WA16 0TE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 35520380001 | ||||
JOHNSON, Kevin | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | England | British | Supply Chain Director | 119165930003 | ||||
KENYON, Paul | Director | 2 Lawrence Road Hazel Grove SK7 4JB Stockport Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 87379250001 | ||||
KITCHINER, John David | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | England | British | Director | 272823350001 | ||||
LAMONT, Douglas | Director | 38 Pyrton Lane OX49 5LX Watlington Oxfordshire | British | Director | 78288300001 | |||||
LEARY, David James | Director | 6 Cambridge Avenue Wylde Green B73 5NA Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Director/Secretary | 74092310001 | |||||
LOUSADA, Charles Terence | Director | Estate Office Crawley Park MK42 0UU Husborne Crawley Bedford | England | British | Director | 94444470001 | ||||
LOUSADA, Simon Charles | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | United Kingdom | British | Director | 238451070001 | ||||
LOUSADA, Simon Charles | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | England | British | Director | 16199140003 | ||||
STEPHENSON, Melvyn | Director | Latchets Pikey Close Pikey Lane LL12 8TU Gresford Clwyd | British | Director | 1541070001 | |||||
STEVENSON, Geoffrey William | Director | Rousham OX25 4QU Bicester East Wing Oxfordshire England | England | British | Director | 25746880009 | ||||
STEVENSON, James Robert | Director | 248a Marylebone Road NW1 6BB London 5th Floor, Grove House | England | British | Commercial Director | 116069520001 | ||||
WRIGHT, Robin | Director | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | United Kingdom | British | Operations Director | 116069120001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TIBC LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Bathrooms Limited | 07 jul 2020 | Empire Close Aldridge WS9 8UD Walsall Units 1 To 7 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Geoffrey William Stevenson | 06 abr 2016 | Units 1-7 Empire Industrial Estate, Brickyard Road WS9 8XT Aldridge West Midlands | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene TIBC LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 04 nov 2020 Entregado el 06 nov 2020 | Pendiente | ||
Breve descripción The chattels listed in schedule 1 to the charge and beginning with the dexion speedlock warehouse boltless pallet racking, 118 bays, consisting of 347 uprights and 708 crossbeams. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 sept 2017 Entregado el 05 sept 2017 | Pendiente | ||
Breve descripción No specific land, ship, aircraft or intellectual property registered (or required to be registered) in the UK is subject to this fixed charge or fixed security. However, please refer to the instrument for full details of the security contained therein. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 30 sept 2016 Entregado el 18 oct 2016 | Pendiente | ||
Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 23 sept 2016 Entregado el 28 sept 2016 | Pendiente | ||
Breve descripción All freehold and leasehold property owned by the company at the charge creation date together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All future freehold and leasehold property of the company together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All present and future patents, patent applications, trade marks and service marks (whether registered or not), design rights (whether registered or not), copyrights and all other intellectual property rights whatsoever and all rights relating thereto (including, without limitation, by way of license) legally or beneficially owned by the company. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 ene 2010 Entregado el 16 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 29 sept 1988 Entregado el 06 oct 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings at northgate way aldridge west midlands t/n wm 437472 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 24 feb 1988 Entregado el 09 mar 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene TIBC LTD algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0