CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02197301 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 26-28 Bedford Row WC1R 4HE London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CHARTERHOUSE SECOND VENTURE FUND MANAGEMENT LIMITED | 02 mar 1988 | 02 mar 1988 |
| LEGIBUS 1064 LIMITED | 20 nov 1987 | 20 nov 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7DX a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE el 23 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lionel Lucien Marie Giacomotto como director el 11 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Gordon Bonnyman como director el 11 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Simon Edward Arnell como director el 11 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Duncan Aldred como director el 11 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Lionel Lucien Marie Giacomotto el 13 nov 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2018 au 31 dic 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
legacy | 4 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Nigel Burrow el 14 dic 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Douglas Simpson como director el 31 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATSON, Irina | Secretario | Bedford Row WC1R 4HE London 26-28 | 174677240001 | |||||||
| BURROW, Paul Nigel | Director | Paternoster Square EC4M 7DX London Warwick Court United Kingdom | England | British | 183952300002 | |||||
| PATRICK, Thomas Spencer | Director | Bedford Row WC1R 4HE London 26-28 | United Kingdom | British | 88140270003 | |||||
| DAS, Biswajit | Secretario | 35 Lullington Garth N12 7LT London | British | 32730500001 | ||||||
| GERMAN, Leslie Francis | Secretario | 7 Chapel Lane Hempstead ME7 3TD Gillingham Kent | British | 3482110001 | ||||||
| LAW, Linda May | Secretario | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | English | 61157950002 | ||||||
| ALDRED, Duncan | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 151584290001 | |||||
| ARBUTHNOTT, Geoffrey James | Director | Lower Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RX St Albans Lamer Hill Hertfordshire | United Kingdom | British | 66364270001 | |||||
| ARNELL, James Simon Edward | Director | Paternoster Square EC4M 7DX London Warwick Court United Kingdom | England | British | 84362710004 | |||||
| ARNELL, James Simon Edward | Director | Bounty Cottage The Street BN6 9DJ Albourne West Sussex | British | 84362710002 | ||||||
| BENNINGTON, William James | Director | 37 Cheyne Court Flood Street SW3 5TR London | American | 42582130002 | ||||||
| BONNYMAN, James Gordon | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 1250620002 | |||||
| BRAKELL, John Russell | Director | 19 Willows Path KT18 7TD Epsom Surrey | British | 33183840002 | ||||||
| COX, Edward George | Director | Sopwell Lodge 15 Milehouse Lane AL1 1TH St Albans Hertfordshire | England | British | 23797950001 | |||||
| DOCKERAY, William Bruce Denne | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 66516980001 | |||||
| DUNCAN, David Richard Louis | Director | 12 Lansdowne Crescent W11 2NJ London | British | 2894030001 | ||||||
| GIACOMOTTO, Lionel Lucien Marie | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | United Kingdom | French | 65194340002 | |||||
| GREENHALGH, Jeremy Edward | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 176295030001 | |||||
| GREENHALGH, Jeremy Edward | Director | 4 West Side Common Wimbledon SW19 4TN London West Lodge | England | British | 128513820001 | |||||
| JANNEY III, Stuart | Director | 135 East Baltimore Street Baltimore Maryland 21202 Usa | American | 34498550001 | ||||||
| MAY, Anthony Roger | Director | Danefield Broom Park Langton Green TN3 0RF Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 19247140002 | |||||
| NICHOLLS, Jill Nicola | Director | 97 Noel Road N1 8HD London | British | 8485240002 | ||||||
| OFFORD, Malcolm Ian | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | United Kingdom | British | 58718940003 | |||||
| PILGRIM, Roger Granville | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 7357660004 | |||||
| PLANT, Thomas Roland | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | England | British | 37560170003 | |||||
| PLANT, Thomas Roland | Director | Marley Lodge Marley Heights GU27 3LU Haslemere Surrey | England | British | 37560170003 | |||||
| SHELDON, Ronald Frank | Director | 8 Oakland Avenue BR4 9LE West Wickham Kent | British | 33770320002 | ||||||
| SIMPSON, Stuart Douglas | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7DX London | United Kingdom | British | 99057720002 | |||||
| SIMPSON, Stuart Douglas | Director | 2 Wadham Gardens NW3 3DP London | England | British | 99057720001 | |||||
| TYNE, William John | Director | 4 St Albans Grove W8 5PN London | United Kingdom | British | 7771150001 | |||||
| WALKER, John, Dr | Director | Fairlawn Christchurch Road GU25 4PJ Wentworth Surrey | British | 49739170001 | ||||||
| WHALLEY, Anthony | Director | 322 Cromwell Tower Barbican EC2Y 8NB London | British | 1979060002 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 17 ene 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 27 nov 2002 Entregado el 04 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0