DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED

DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 02197841
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Misceláneos

    Forms b & z convert to registered society
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to registered society 25/11/2015
    RES13

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 25 nov 2015

    • Capital: GBP 60,102
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 dic 2015

    • Capital: GBP 60,101
    3 páginasSH01

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2015

    Estado de capital el 02 sept 2015

    • Capital: GBP 60,100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 sept 2014

    Estado de capital el 16 sept 2014

    • Capital: GBP 60,100
    SH01

    Nombramiento de Andrew Paul Lang como director el 30 jun 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Patrick Moynihan como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 mar 2014

    Estado de capital el 06 mar 2014

    • Capital: GBP 60,100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Patrick Moynihan el 06 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Paul Hemingway como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Patrick Moynihan como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Cws (No.1) Limited como director

    2 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Michael Greenacre como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Braithwaite como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Paul Andrew Hemingway el 31 jul 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150155530001
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    BREARLEY, June Mary
    Branton Cottage Back Lane
    Clayton
    DN5 7DG Doncaster
    S Yorks
    Secretario
    Branton Cottage Back Lane
    Clayton
    DN5 7DG Doncaster
    S Yorks
    British27640100001
    BREARLEY, Shaun Harold
    9 Roe Croft Close
    Sprotbrough
    DN5 7QB Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    9 Roe Croft Close
    Sprotbrough
    DN5 7QB Doncaster
    South Yorkshire
    British13697850003
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    BritishSecretarial Administrator110230860001
    GILL, Alan
    Stubbing 58 Denshaw Road
    Delph
    OL3 5EU Oldham
    Lancashire
    Secretario
    Stubbing 58 Denshaw Road
    Delph
    OL3 5EU Oldham
    Lancashire
    BritishManager15085630002
    MAYNARD, Christopher Roland
    14 St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    14 St Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    BritishManager94158510001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secretario corporativo
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Director
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    BREARLEY, Shaun Harold
    Branton Cottage
    Back Lane Clayton
    DN5 7DG Doncaster
    S Yorks
    Director
    Branton Cottage
    Back Lane Clayton
    DN5 7DG Doncaster
    S Yorks
    BritishDirector13697850001
    DALEY, Paul Nicholas
    The Barn Widesdon Lane
    Dunford Bridge
    S36 4TF Sheffield
    Director
    The Barn Widesdon Lane
    Dunford Bridge
    S36 4TF Sheffield
    BritishTravel General Mr75243590001
    GILL, Alan
    Stubbing 58 Denshaw Road
    Delph
    OL3 5EU Oldham
    Lancashire
    Director
    Stubbing 58 Denshaw Road
    Delph
    OL3 5EU Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishManager15085630002
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Director
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritishGeneral Manager - Travel74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Director
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritishHead Of Tax And Treasury188221460001
    HOLLING, Martin
    Mill Farm House
    Oxspring
    S36 7YE Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Mill Farm House
    Oxspring
    S36 7YE Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector73200330001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant87719730001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Director
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritishSolicitor182256460001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Director corporativo
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    ¿Tiene DUNSTAN BREARLEY TRAVEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 09 oct 1997
    Entregado el 17 oct 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all deposit(s) in and to charged deposit contract with barclays bankm PLC re;-dunstan brearley travel limited gts bid deposit bid number 24779509.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 1997Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 06 nov 1996
    Entregado el 12 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    14 and 16 high st,wombwell,barnsley,south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balance
    Creado el 26 sept 1995
    Entregado el 05 oct 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the deposits together with all interest in an account no 60727725. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 1995Registro de un cargo (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 13 may 1994
    Entregado el 20 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the deposits together with interest in an account no 00141003.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 21 ene 1994
    Entregado el 01 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the deposits together with interest in account no 00141003. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 feb 1992
    Entregado el 27 feb 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    40-42 pasture road goole humberside (even numbers only).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 1992Registro de un cargo (395)
    Letter of charge
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 17 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys standing to the credit of any account(s) of the company with the bank re: dunstan brearley travel limited business premium account.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 sept 1991Registro de una carga
    • 26 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 abr 1991
    Entregado el 01 may 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    14 & 16 high street, wombwell, barnsley, south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 1991Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 16 feb 1988
    Entregado el 01 mar 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    14 and 16 high st, wombell barnsley, south yorkshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1988Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0