TALBOT UNDERWRITING LTD
Visión general
Nombre de la empresa | TALBOT UNDERWRITING LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02202362 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TALBOT UNDERWRITING LTD?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra TALBOT UNDERWRITING LTD?
Dirección de la sede social | The Aig Building 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TALBOT UNDERWRITING LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ALLEGHANY UNDERWRITING LTD | 31 mar 2000 | 31 mar 2000 |
UNDERWRITERS RE AGENCIES LTD | 01 oct 1999 | 01 oct 1999 |
VENTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED | 19 abr 1988 | 19 abr 1988 |
MINMAR (34) LIMITED | 03 dic 1987 | 03 dic 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TALBOT UNDERWRITING LTD?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TALBOT UNDERWRITING LTD?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jul 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 05 ago 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jul 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TALBOT UNDERWRITING LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Thomas Allen Bolt como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr James Peter Middleton como secretario el 05 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 30 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 60 Threadneedle Street London EC2R 8HP a The Aig Building 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB el 23 may 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Edward Arscott Carpenter como director el 31 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Marie-Claire Gallagher como secretario el 03 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Barnabas John Hurst-Bannister como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Melanie Elizabeth Hind el 07 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew Scales como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Melanie Elizabeth Hind como director el 07 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Richard David Cowling como director el 26 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Katherine Ann Coates como director el 12 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nicola Monica Alexia Burch como director el 12 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 27 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Catherine Elizabeth Barton como director el 31 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Russell Eric Bean como director el 14 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Ernest Morris como director el 08 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher John Roland Rash como director el 08 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Lawton Hancock como director el 07 dic 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de TALBOT UNDERWRITING LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDLETON, James Peter | Secretario | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | 324004330001 | |||||||
BATCHELOR, David John | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Director | 263171340001 | ||||
BEAN, Russell Eric | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Underwriter | 156292360002 | ||||
COATES, Katherine Ann | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Solicitor | 289547720001 | ||||
COWLING, Richard David | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Chief Financial Officer | 234737410003 | ||||
HANCOCK, Jon Lawton, Mr. | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Director | 162408740002 | ||||
HIND, Melanie Elizabeth | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | Non-Executive Director | 296826500001 | ||||
RASH, Christopher John Roland | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Accountant | 181443950001 | ||||
ROSS, Julian Graeme | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | England | British | Actuary | 74646490005 | ||||
CLOUTING, Jane Sarah, Ms. | Secretario | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | British | Underwriting Agent | 29628630009 | |||||
GALLAGHER, Marie-Claire | Secretario | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | 251010740001 | |||||||
WILCOX, Graham Bernard | Secretario | Smithy Farm Barrow On Trent DE73 1HJ Derby | British | 50526710001 | ||||||
ALWEN, Roger Norman | Director | 11 Bywater Street Chelsea SW3 4XD London | British | Lloyds Underwriter | 14306470002 | |||||
ATKIN, Charles Neville Rupert | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | United Kingdom | British | Lloyd'S Underwriter | 15395560002 | ||||
BARTON, Catherine Elizabeth | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | Actuary | 275876950001 | ||||
BILSBY, Peter Antony | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | None | 150915450001 | ||||
BOLT, Thomas Allen | Director | 58 Fenchurch Street EC3M 4AB London The Aig Building England | United States | American | Director | 251226350001 | ||||
BONVARLET, Gilles Alex Maxime | Director | 11 Acfold Road SW6 2AJ London | England | British | Chief Operating Officer | 46610410003 | ||||
BROOKS, Andrew Lewis | Director | 53 Morley Road TW1 2HG Twickenham Middlesex | British | Under Writer | 46120610002 | |||||
BURCH, Nicola Monica Alexia | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | Solicitor | 229078650001 | ||||
CARPENTER, Michael Edward Arscott | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | Chief Executive | 29705360001 | ||||
CHURCHILL, Paul Christopher | Director | 15 King Alfred Place Hyde SO23 7DF Winchester Hampshire | British | Director | 46120570002 | |||||
CLOUTING, Jane Sarah, Ms. | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | Underwriting Agent | 29628630009 | ||||
CONSOLINO, Joseph Evans | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | Bermuda | American | Accountant | 123596310001 | ||||
COWELL, Peter Harry | Director | Elmfield Hook Green Road DA13 9NQ Southfleet Kent | United Kingdom | British | Finance Director | 188870360001 | ||||
FENN, John David | Director | Seasons 105 Hill Avenue SS11 8LP Wickford Essex | British | Lloyds Underwriter | 9777990001 | |||||
GILLIAM, Dorothea Cooke | Director | 44 Washington Circle 60521 Hinsdale Illinois Usa | American | Vice President | 70473420001 | |||||
GREENBERG, Jeffrey Wayne | Director | 950 Park Avenue Apartment 10b New York Ny 10028 Usa | United States | American | Venture Capitalist | 212071760001 | ||||
HART, Robert Michael | Director | 16 Sunny Brae Place Bronxville 10708 Westchester County New York United States Of America | American | Senior Vp,General Counsel &Sec | 61946490001 | |||||
HENDRICKSON, John Joseph | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | United States Of America | American | Non-Executive Director | 184067220001 | ||||
HESS, Todd Joseph | Director | 20 The Drive TN13 3AE Sevenoaks Kent | American | Managing Director | 64238590001 | |||||
HOTCHKISS JR, Winchester Fitch | Director | 201 Michigan Road New Canaan Connecticut Usa | American | Investment Advisor | 43266140002 | |||||
HURST-BANNISTER, Barnabas John | Director | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 | England | British | None | 37504990002 | ||||
HUTTER, Heidi Elisabeth | Director | 11209 Solitary Fawn Trail Austin Tx 78735 Usa | United Kingdom | American | Director | 36131540004 | ||||
JOHN, Russell Thomas | Director | 4948 Summit View Drive Westlake Village 91362 California U S A | Usa | President | 49449440002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TALBOT UNDERWRITING LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talbot Underwriting Holdings Ltd. | 06 abr 2016 | Threadneedle Street EC2R 8HP London 60 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene TALBOT UNDERWRITING LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Creado el 01 abr 2004 Entregado el 08 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in relation to all cash calls (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge in relation to the syndicate 1183 2002 dollar borrowing group between the borrowing group,the dollar trustees,the sterling trustees,the managing agent and lloyds tsb bank PLC | Creado el 09 jul 2002 Entregado el 17 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrowing group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right,title and interest in relation to all cash calls. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of chargebetween the borrowing group, the managing agent, lloyds tsb bank PLC and the sterling trustees (all as defined) | Creado el 14 mar 2002 Entregado el 03 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in and ot all such cash calls as are made by the managing agent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0