TALBOT UNDERWRITING LTD

TALBOT UNDERWRITING LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTALBOT UNDERWRITING LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02202362
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TALBOT UNDERWRITING LTD?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Dirección de la sede social
    The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALLEGHANY UNDERWRITING LTD31 mar 200031 mar 2000
    UNDERWRITERS RE AGENCIES LTD01 oct 199901 oct 1999
    VENTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED19 abr 198819 abr 1988
    MINMAR (34) LIMITED03 dic 198703 dic 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TALBOT UNDERWRITING LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta22 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence05 ago 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta22 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Thomas Allen Bolt como director el 31 dic 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 22 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Peter Middleton como secretario el 05 jun 2024

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    30 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 60 Threadneedle Street London EC2R 8HP a The Aig Building 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB el 23 may 2024

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Arscott Carpenter como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Marie-Claire Gallagher como secretario el 03 abr 2024

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Barnabas John Hurst-Bannister como director el 31 dic 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Melanie Elizabeth Hind el 07 jun 2022

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Matthew Scales como director el 30 jun 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Melanie Elizabeth Hind como director el 07 jun 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard David Cowling como director el 26 abr 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Katherine Ann Coates como director el 12 nov 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nicola Monica Alexia Burch como director el 12 nov 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    27 páginasAA

    Cese del nombramiento de Catherine Elizabeth Barton como director el 31 ago 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Russell Eric Bean como director el 14 may 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Ernest Morris como director el 08 feb 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher John Roland Rash como director el 08 feb 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jonathan Lawton Hancock como director el 07 dic 2020

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIDDLETON, James Peter
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Secretario
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    324004330001
    BATCHELOR, David John
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishDirector263171340001
    BEAN, Russell Eric
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishUnderwriter156292360002
    COATES, Katherine Ann
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishSolicitor289547720001
    COWLING, Richard David
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer234737410003
    HANCOCK, Jon Lawton, Mr.
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishDirector162408740002
    HIND, Melanie Elizabeth
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishNon-Executive Director296826500001
    RASH, Christopher John Roland
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishAccountant181443950001
    ROSS, Julian Graeme
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    EnglandBritishActuary74646490005
    CLOUTING, Jane Sarah, Ms.
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Secretario
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    BritishUnderwriting Agent29628630009
    GALLAGHER, Marie-Claire
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Secretario
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    251010740001
    WILCOX, Graham Bernard
    Smithy Farm Barrow On Trent
    DE73 1HJ Derby
    Secretario
    Smithy Farm Barrow On Trent
    DE73 1HJ Derby
    British50526710001
    ALWEN, Roger Norman
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    Director
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    BritishLloyds Underwriter14306470002
    ATKIN, Charles Neville Rupert
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    United KingdomBritishLloyd'S Underwriter15395560002
    BARTON, Catherine Elizabeth
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishActuary275876950001
    BILSBY, Peter Antony
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishNone150915450001
    BOLT, Thomas Allen
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    United StatesAmericanDirector251226350001
    BONVARLET, Gilles Alex Maxime
    11 Acfold Road
    SW6 2AJ London
    Director
    11 Acfold Road
    SW6 2AJ London
    EnglandBritishChief Operating Officer46610410003
    BROOKS, Andrew Lewis
    53 Morley Road
    TW1 2HG Twickenham
    Middlesex
    Director
    53 Morley Road
    TW1 2HG Twickenham
    Middlesex
    BritishUnder Writer46120610002
    BURCH, Nicola Monica Alexia
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishSolicitor229078650001
    CARPENTER, Michael Edward Arscott
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishChief Executive29705360001
    CHURCHILL, Paul Christopher
    15 King Alfred Place
    Hyde
    SO23 7DF Winchester
    Hampshire
    Director
    15 King Alfred Place
    Hyde
    SO23 7DF Winchester
    Hampshire
    BritishDirector46120570002
    CLOUTING, Jane Sarah, Ms.
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishUnderwriting Agent29628630009
    CONSOLINO, Joseph Evans
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    BermudaAmericanAccountant123596310001
    COWELL, Peter Harry
    Elmfield
    Hook Green Road
    DA13 9NQ Southfleet
    Kent
    Director
    Elmfield
    Hook Green Road
    DA13 9NQ Southfleet
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director188870360001
    FENN, John David
    Seasons 105 Hill Avenue
    SS11 8LP Wickford
    Essex
    Director
    Seasons 105 Hill Avenue
    SS11 8LP Wickford
    Essex
    BritishLloyds Underwriter9777990001
    GILLIAM, Dorothea Cooke
    44 Washington Circle
    60521 Hinsdale
    Illinois
    Usa
    Director
    44 Washington Circle
    60521 Hinsdale
    Illinois
    Usa
    AmericanVice President70473420001
    GREENBERG, Jeffrey Wayne
    950 Park Avenue
    Apartment 10b
    New York
    Ny 10028
    Usa
    Director
    950 Park Avenue
    Apartment 10b
    New York
    Ny 10028
    Usa
    United StatesAmericanVenture Capitalist212071760001
    HART, Robert Michael
    16 Sunny Brae Place
    Bronxville 10708
    Westchester County
    New York
    United States Of America
    Director
    16 Sunny Brae Place
    Bronxville 10708
    Westchester County
    New York
    United States Of America
    AmericanSenior Vp,General Counsel &Sec61946490001
    HENDRICKSON, John Joseph
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    United States Of AmericaAmericanNon-Executive Director184067220001
    HESS, Todd Joseph
    20 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Director
    20 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    AmericanManaging Director64238590001
    HOTCHKISS JR, Winchester Fitch
    201 Michigan Road
    New Canaan
    Connecticut
    Usa
    Director
    201 Michigan Road
    New Canaan
    Connecticut
    Usa
    AmericanInvestment Advisor43266140002
    HURST-BANNISTER, Barnabas John
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    Director
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    EnglandBritishNone37504990002
    HUTTER, Heidi Elisabeth
    11209 Solitary Fawn Trail
    Austin
    Tx 78735
    Usa
    Director
    11209 Solitary Fawn Trail
    Austin
    Tx 78735
    Usa
    United KingdomAmericanDirector36131540004
    JOHN, Russell Thomas
    4948 Summit View Drive
    Westlake Village
    91362 California
    U S A
    Director
    4948 Summit View Drive
    Westlake Village
    91362 California
    U S A
    UsaPresident49449440002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TALBOT UNDERWRITING LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Talbot Underwriting Holdings Ltd.
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    England
    06 abr 2016
    Threadneedle Street
    EC2R 8HP London
    60
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish
    Lugar de registroRegistrar Of Companies For England, Wales & Scotland
    Número de registro2180028
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TALBOT UNDERWRITING LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 01 abr 2004
    Entregado el 08 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in relation to all cash calls (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1183 2002 dollar borrowing group between the borrowing group,the dollar trustees,the sterling trustees,the managing agent and lloyds tsb bank PLC
    Creado el 09 jul 2002
    Entregado el 17 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowing group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right,title and interest in relation to all cash calls. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 07 may 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of chargebetween the borrowing group, the managing agent, lloyds tsb bank PLC and the sterling trustees (all as defined)
    Creado el 14 mar 2002
    Entregado el 03 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and ot all such cash calls as are made by the managing agent. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0