VINECOMB INVESTMENTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | VINECOMB INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02206022 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
- Venta al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados (47710) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 28 abr 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 abr 2019 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Thomas James Piper como secretario el 01 jul 2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Cameron John Olsen como secretario el 01 jul 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr Alastair Peter Orford Dick el 01 may 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Alastair Peter Orford Dick como director el 14 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 14 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Notification de Vinecomb Investments Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 feb 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||
Notification de Vinecomb Investment Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 feb 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Jonmarc Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 feb 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Charles Harry Kofler en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 feb 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 abr 2018 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2017 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 ago 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 6 | 6 páginas | MR04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 6C Sinfin Central Business Park Sinfin Lane Derby Derbyshire DE24 9GL a Unit a Brook Park East Shirebrook NG20 8RY el 22 feb 2017 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Cameron John Olsen como secretario el 22 feb 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2017 au 30 abr 2017 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Miss Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 08 feb 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Adedotun Ademola Adegoke como director el 08 feb 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPER, Thomas James | Secretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260011650001 | |||||||
ADEGOKE, Adedotun Ademola | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Senior Buyer | 203129860001 | ||||
DICK, Alastair Peter Orford | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 256598390002 | ||||
OLSEN, Cameron John | Secretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 225286690001 | |||||||
PARKER, Jenette | Secretario | 92 Swanmore Road Littleover DE23 3SY Derby Derbyshire | British | 20503800001 | ||||||
KOFLER, Charles Harry | Director | 15 Montpelier Quarndon DE22 5JW Derby Farnhill England | England | British | Mens Outfitter | 3262790005 | ||||
STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Director | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Customs And Vat | 245592990001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de VINECOMB INVESTMENTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinecomb Investments Holdings Limited | 08 feb 2017 | Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Unit A England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Vinecomb Investment Holdings Limited | 08 feb 2017 | Brook Park East Road Shirebrook NG20 8RY Mansfield Unit A England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Jonmarc Investments Limited | 06 abr 2016 | Sinfin Central Business Park Sinfin Lane DE24 9GL Derby Unit 6c Derbyshire England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Charles Harry Kofler | 06 abr 2016 | 15 Montpelier Quarndon DE22 5JW Derby Farnhill England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene VINECOMB INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 05 abr 2016 Entregado el 21 abr 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Second debenture | Creado el 02 sept 2010 Entregado el 04 sept 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 sept 2009 Entregado el 02 sept 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property k/a 17 enterprise way jubilee parkway off stores road derby. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 06 ene 1992 Entregado el 13 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 26 jul 1991 Entregado el 02 ago 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 22A parker foundry mansfield road, derby and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 16 ene 1991 Entregado el 22 ene 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 8 midland road derby t/no. DY160357 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 07 dic 1988 Entregado el 08 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H - property k/a or being 8 midland road, derby, derbyshire title no - dy 160357 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0