OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED

OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02207105
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    • Otras ediciones de software (58290) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Fleet Mill A Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OPEN SYSTEMS MARKETING LIMITED01 feb 198901 feb 1989
    I.T. EXPORTS LIMITED21 dic 198721 dic 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 29 jun 2015

    • Capital: GBP 0.01
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 27/06/2015
    RES13

    Cese del nombramiento de Janet Marie Dryer como director el 26 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 feb 2015

    Estado de capital el 24 feb 2015

    • Capital: GBP 99,094.82
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA

    Misceláneos

    Auditors resignation
    1 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 feb 2014

    Estado de capital el 04 feb 2014

    • Capital: GBP 99,094.82
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    13 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * the Courtyard High Street Ascot Berkshire SL5 7HP* el 24 jun 2013

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    14 páginasAA

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 31 ene 2012

    17 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    13 mar 2012A second filed AR01 was registered on 13/03/2012

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2011

    8 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    20 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Mark Ties como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Mark E Ties como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Konrad Litwin como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Konrad Litwin como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TIES, Mark
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    Secretario
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    162396740001
    TIES, Mark Edward
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    Director
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    United StatesAmericanDirector172902510001
    BAKER, Warren Bryce Rezvan
    3 Arundel Court
    Raymond Road Wimbledon
    SW19 4AF London
    Secretario
    3 Arundel Court
    Raymond Road Wimbledon
    SW19 4AF London
    British35221040001
    COAKLEY, Anne Barbara
    West House
    Milford Road Elstead
    GU8 6HF Godalming
    Surrey
    Secretario
    West House
    Milford Road Elstead
    GU8 6HF Godalming
    Surrey
    British126965690001
    COAKLEY, Anne Barbara
    West House
    Milford Road Elstead
    GU8 6HF Godalming
    Surrey
    Secretario
    West House
    Milford Road Elstead
    GU8 6HF Godalming
    Surrey
    British126965690001
    JACKSON, Leslie Ivan
    11 Complins
    Holybourne
    GU34 4EH Alton
    Hampshire
    Secretario
    11 Complins
    Holybourne
    GU34 4EH Alton
    Hampshire
    British51045200002
    LITWIN, Konrad Adam
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    Secretario
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    British160234680001
    BAKER, Warren Bryce Rezvan
    3 Arundel Court
    Raymond Road Wimbledon
    SW19 4AF London
    Director
    3 Arundel Court
    Raymond Road Wimbledon
    SW19 4AF London
    United KingdomBritishCompany Director35221040001
    CHANEY, Marjorie Jean
    Pemberley Woodlands Ride
    SL5 9HP South Ascot
    Berkshire
    Director
    Pemberley Woodlands Ride
    SL5 9HP South Ascot
    Berkshire
    BritishBook Keeper59516510001
    CHANEY, Neil Martin
    11a Conon Road
    Applecross
    FOREIGN Western Australia
    6153
    Australia
    Director
    11a Conon Road
    Applecross
    FOREIGN Western Australia
    6153
    Australia
    AustraliaBritishCompany Director67509980003
    CHANEY, Neil Martin
    Pemberley
    Woodlands Ride
    SL5 9HP South Ascot
    Berkshire
    Director
    Pemberley
    Woodlands Ride
    SL5 9HP South Ascot
    Berkshire
    BritishManaging Director67509980001
    DRYER, Janet Marie
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    Director
    Infineon House
    Minley Road
    GU51 2RD Fleet
    Fleet Mill A
    Hampshire
    UsaUnited States Of AmericaDirector160547580001
    FAGAN, Raymond John
    23 Woodfield Road
    Ealing
    W5 1SL London
    Director
    23 Woodfield Road
    Ealing
    W5 1SL London
    United KingdomBritishNon Executive Chairman8185690001
    JACKSON, Leslie Ivan
    11 Complins
    Holybourne
    GU34 4EH Alton
    Hampshire
    Director
    11 Complins
    Holybourne
    GU34 4EH Alton
    Hampshire
    BritishComputer Analyst51045200002
    LINES, David Hilary
    23 Malden Hill Gardens
    KT3 4HS New Malden
    Surrey
    Director
    23 Malden Hill Gardens
    KT3 4HS New Malden
    Surrey
    BritishSales Manager51045070001
    LITWIN, Konrad Adam
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    Director
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    EnglandBritishDirector71334400003
    STEARS, Peter John
    15 Cornwall Close
    Wokingham
    RG41 3AG Berkshire
    Berkshire
    Director
    15 Cornwall Close
    Wokingham
    RG41 3AG Berkshire
    Berkshire
    BritishSoftware Development Manager65739880001

    ¿Tiene OPEN SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 27 jun 2008
    Entregado el 04 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £36,044.96 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All sums that may be paid to bhse general partner limited acting as general partner of bhse limited partnership and bhse nominee limited under the terms of the rent deposit deed see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bhse General Partner Limited
    Transacciones
    • 04 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge of deposit
    Creado el 27 nov 2002
    Entregado el 10 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 90001311 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 ene 2000
    Entregado el 04 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 feb 1997
    Entregado el 11 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over credit balances
    Creado el 19 feb 1997
    Entregado el 24 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee in favour of storage technology LTD for £234,375.
    Breve descripción
    The sum of £234,375 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 68577303 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A registered charge
    Creado el 02 jun 1989
    Entregado el 06 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an under terms dated 2/6/89
    Breve descripción
    £2,250 two thousand and fifty pounds.
    Personas con derecho
    • Omex Agriculture Limited
    Transacciones
    • 06 jun 1989Registro de una carga
    • 18 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0