CTC MANAGEMENT LIMITED

CTC MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCTC MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02215196
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CTC MANAGEMENT LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Standard House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RICHARDS HOGG LINDLEY LIMITED09 ene 199809 ene 1998
    RICHARDS HOGG LIMITED05 may 198805 may 1988
    LEGIBUS 1128 LIMITED29 ene 198829 ene 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 04/11/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Damian Ely el 01 oct 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr George William Fitzsimons el 01 oct 2012

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de George William Fitzsimons como director el 31 oct 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Ivan John Keane como director el 16 jul 2012

    3 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Charles Taylor Administration Services Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Robert Bird como secretario

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 10 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CTC MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Secretario corporativo
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3413040
    157558200001
    ELY, Thomas Damian
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    Director
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    EnglandBritish59348270003
    KEANE, Ivan John
    House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard
    England
    Director
    House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard
    England
    EnglandBritish65092840002
    BERRY, John Gordon
    Flat 20b
    20 The Barons
    TW1 2AP Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    Flat 20b
    20 The Barons
    TW1 2AP Twickenham
    Middlesex
    British37142130001
    BIRD, Robert Arthur
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    Secretario
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    British23723280001
    BRICKNELL, Sarah Louise
    105b Tranmere Road
    Earlsfield
    SW18 3QP London
    Secretario
    105b Tranmere Road
    Earlsfield
    SW18 3QP London
    British45306460001
    RAYNER, John Henry
    Emperor House 35 Vine Street
    EC3N 2RH London
    Secretario
    Emperor House 35 Vine Street
    EC3N 2RH London
    British1564830001
    AHERN, John Richard
    Comptons Cottage
    55 Brighton Road
    RH13 6EZ Horsham
    West Sussex
    Director
    Comptons Cottage
    55 Brighton Road
    RH13 6EZ Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish70339340002
    ALLEN, Jeffery Charles
    5 Deben Road
    CO4 3UZ Colchester
    Essex
    Director
    5 Deben Road
    CO4 3UZ Colchester
    Essex
    British37267240001
    ANDERSEN, Julian Nils
    14 Giles Coppice
    Dulwich
    SE19 1XF London
    Director
    14 Giles Coppice
    Dulwich
    SE19 1XF London
    British19161380001
    BARSTOW, Christopher John
    Aros Courts Hill Road
    GU27 2PN Haslemere
    Surrey
    Director
    Aros Courts Hill Road
    GU27 2PN Haslemere
    Surrey
    British17360670001
    BROWNE, Dennis Walter
    71 Steep Hill
    CR0 5QU Croydon
    Surrey
    Director
    71 Steep Hill
    CR0 5QU Croydon
    Surrey
    British57870460001
    BYCROFT, Geoffrey
    The Grange Church Lane
    London Thorpe
    NG31 9RX Grantham
    Lincolnshire
    Director
    The Grange Church Lane
    London Thorpe
    NG31 9RX Grantham
    Lincolnshire
    British16664220001
    CLARKE, Stephen Andrew
    6 Esmond Road
    Chiswick
    W4 1JQ London
    Director
    6 Esmond Road
    Chiswick
    W4 1JQ London
    EnglandBritish42862450003
    COLE, Douglas Andrew
    7 Lake Road
    TN4 8XT Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    7 Lake Road
    TN4 8XT Tunbridge Wells
    Kent
    British38310860002
    CORNAH, Richard Ralph
    12 Kirby Park
    West Kirby
    L48 2HA Wirral
    Merseyside
    Director
    12 Kirby Park
    West Kirby
    L48 2HA Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish30854980001
    CROSS, James Frederick
    72 Rede Court Road
    Strood
    ME2 3TF Rochester
    Kent
    Director
    72 Rede Court Road
    Strood
    ME2 3TF Rochester
    Kent
    EnglandBritish28507550001
    DUNCAN, Joseph Miles
    Home Farm Landican
    L49 5LJ Birkenhead
    Merseyside
    Director
    Home Farm Landican
    L49 5LJ Birkenhead
    Merseyside
    EnglandBritish282748720002
    ELLIOT, Gordon Henry
    11 Maltbys
    Selborne
    GU34 3LT Alton
    Hampshire
    Director
    11 Maltbys
    Selborne
    GU34 3LT Alton
    Hampshire
    British46887780002
    FITZSIMONS, George William
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    Director
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    United KingdomBritish105693390001
    GROOM, Alistair John
    The Rectory
    East Martin
    SP6 3LJ Fordingbridge
    Hampshire
    Director
    The Rectory
    East Martin
    SP6 3LJ Fordingbridge
    Hampshire
    EnglandBritish38168820003
    HAWKINS, Neil Richard
    15 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Director
    15 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    British57870640001
    HEBDITCH, Charles Silvius
    The Old Rectory
    Fringford
    OX6 9DX Bicester
    Oxfordshire
    Director
    The Old Rectory
    Fringford
    OX6 9DX Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritish47877070001
    JONES, Keith
    The Chestnuts Packhorse Road
    Bessels Green
    TN13 2QR Sevenoaks
    Kent
    Director
    The Chestnuts Packhorse Road
    Bessels Green
    TN13 2QR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish47481830001
    MACDONALD, John Alan
    Sheephatch House Sheephatch Lane
    Tilford
    GU10 2AQ Farnham
    Surrey
    Director
    Sheephatch House Sheephatch Lane
    Tilford
    GU10 2AQ Farnham
    Surrey
    British58593730001
    MAROUNGA PANAYOTOPOULOS, Glykeria Niki
    18 Kosti Palama Str
    Neo Psychiko
    FOREIGN Athens 15451 Greece
    Director
    18 Kosti Palama Str
    Neo Psychiko
    FOREIGN Athens 15451 Greece
    Greek41138760001
    MARTIN, Keith James
    23 Chemin Du Parterre
    78630 Morainvilliers
    France
    Director
    23 Chemin Du Parterre
    78630 Morainvilliers
    France
    British27025260002
    MATTHEWS, John Stephen
    79 Hillfield Avenue
    N8 7DS London
    Director
    79 Hillfield Avenue
    N8 7DS London
    EnglandBritish45883160003
    MITCHELL, Michael Egley
    8 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Director
    8 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    British34473380001
    PATON, Andrew Mark
    Bramley Hyrst
    Oldfield Road
    BR1 2LF Bickley
    Kent
    Director
    Bramley Hyrst
    Oldfield Road
    BR1 2LF Bickley
    Kent
    British16664230002
    ROGERS, Nigel John Crispin
    1st/2nd Floor
    70 Eaton Place
    SW1X 8AT London
    Director
    1st/2nd Floor
    70 Eaton Place
    SW1X 8AT London
    British16664180004
    ROWE, John Stephen Martin
    Ixworth Abbey
    Ixworth
    IP31 2HQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    Ixworth Abbey
    Ixworth
    IP31 2HQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish35883210001
    ROWLAND, Paul Oliver
    4 Beddington Road
    Seven Kings
    IG3 8PD Ilford
    Essex
    Director
    4 Beddington Road
    Seven Kings
    IG3 8PD Ilford
    Essex
    EnglandBritish50953380001
    SHEPLEY CUTHBERT, David Charles
    Moors House
    Hook Norton
    OX15 5LS Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Moors House
    Hook Norton
    OX15 5LS Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish49556220001
    SILVER, Paul Philip
    47 Brittains Lane
    TN13 2JP Sevenoaks
    Kent
    Director
    47 Brittains Lane
    TN13 2JP Sevenoaks
    Kent
    British30745170006

    ¿Tiene CTC MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 dic 2005
    Entregado el 06 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 28 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed
    Creado el 20 ene 2004
    Entregado el 27 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC (Acting Through Its Agent, the Royal Bank of Scotland PLC)
    Transacciones
    • 27 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 feb 2002
    Entregado el 26 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 may 1999
    Entregado el 09 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hongkongbank of Australia Limited
    Transacciones
    • 09 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 22 abr 1996
    Entregado el 02 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 22 ene 1992
    Entregado el 25 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over goodwill,bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 20 jul 1988
    Entregado el 02 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 02 ago 1988Registro de una carga
    • 23 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 15 jun 1988
    Entregado el 17 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1988Registro de una carga
    • 17 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0