CEDARVALE
Visión general
Nombre de la empresa | CEDARVALE |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
Número de empresa | 02220037 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CEDARVALE?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CEDARVALE?
Dirección de la sede social | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDARVALE?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PAYSYSTEM LIMITED | 10 feb 1988 | 10 feb 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDARVALE?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CEDARVALE?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 18 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDARVALE?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 15 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 15 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Neeta Shah como director | 3 páginas | RP04AP01 | ||||||
Nombramiento de Neeta Sha como director el 13 feb 2023 | 3 páginas | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cese del nombramiento de Tom Joy como director el 09 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Christopher Paul West como director el 10 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 15 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020 | 15 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 15 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Joanna Martha Henning como director el 12 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr Tom Joy como director el 12 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018 | 14 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr Christopher Paul West como director el 23 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Joseph William Cannon como director el 23 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Nicola Ann Dymond como director el 06 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Robert Louis Carroll como director el 24 jul 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Robert Louis Carroll como secretario el 24 jul 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017 | 14 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de CEDARVALE?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMOND, Nicola Ann | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British | General Manager | 121493350002 | ||||
HENNING, Joanna Martha | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British | Town Planner | 268097060001 | ||||
JONES, Rosemarie Bernadette Katherine | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British | Chartered Surveyor | 62743350006 | ||||
SHAH, Neeta | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British | Head Of Investment Accounting | 306569190001 | ||||
WEIR, John Charles | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British,Irish | Chartered Surveyor And Town Planner | 176919900001 | ||||
BROOKE TURNER, James Evelyn | Secretario | 6 Normanhurst Road SW2 3TA London | British | 40055680001 | ||||||
CANNON, Joseph William | Secretario | 24 Ferndale Road RH15 0HG Burgess Hill West Sussex | Australian | 32306440002 | ||||||
CANNON, Joseph William | Secretario | 31 Newport Road RH15 8QG Burgess Hill West Sussex | British | 32306440001 | ||||||
CARROLL, Robert Louis | Secretario | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | British | 54605410001 | ||||||
HOPKINS, Colin Roy | Secretario | Flat I 151 Plough Way SE16 1FN London | British | 47770940001 | ||||||
MEGGS, Sandra Anne | Secretario | 79 Queen Anne Avenue BR2 0SE Bromley Kent | British | 11814610003 | ||||||
ADAMS, Marian | Director | 9 Birds Hill SG6 1PL Letchworth Hertfordshire | British | Head Of Accounting Services | 48948570001 | |||||
BROWN, Andrew Charles | Director | The Croft 40 Faircross Way AL1 4SD St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 40669790001 | ||||
CANNON, Joseph William | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | United Kingdom | Australian | Surveyor | 32306440002 | ||||
CARROLL, Robert Louis | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | United Kingdom | British | Property Tax Accountant | 54605410001 | ||||
CLARK, Paul Richard | Director | 27 Latham Road TW1 1BN Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Chief Surveyor | 94373770001 | ||||
DAWS, Christopher William | Director | 27 Tufton Court Tufton Street SW1P 3QH London | England | British | Financial Secretary | 94373690001 | ||||
FARRELL, Michael Geoffrey Shaun | Director | 7 Glenwood Close ME7 3RP Hempstead Kent | British | Commmercial Property Manager | 62415880001 | |||||
FENCHELLE, Mark Stephen | Director | 7 Bovill Road Honor Oak Park SE23 1HB London | British | Accountant | 40682770001 | |||||
JOY, Tom | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | United Kingdom | British | Investment Director | 112820520001 | ||||
LINES, Robert John | Director | Ridge Langley CR2 0AS Sanderstead 122 Surrey | Uk | British | Accountant | 152624080001 | ||||
LOCKE, Patrick | Director | 1 Millbank SW1P 3JZ London | British | Secretary Church Commissioners | 7433200001 | |||||
NABARRO, Richard James | Director | 37 Bosman Drive GU20 6JN Windlesham Surrey | British | Ecclesiastical Administrator | 40669860001 | |||||
TAYLERSON, Richard | Director | 49 Dawnay Road KT23 4PE Great Bookham Surrey | England | British | Surveyor | 201599760001 | ||||
WEST, Christopher Paul | Director | 29 Great Smith Street London SW1P 3PS | England | British | Chartered Surveyor | 164817570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CEDARVALE?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cricklewood Trading Estates Limited | 06 abr 2017 | Great Smith Street SW1P 3PS London 29 | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CEDARVALE alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Second mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 18 may 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 5/1/89, a mortgage dated 22/3/89 and this deed. | |
Breve descripción F/H land in the parishes of sevirgton & mersham ashford kent. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Second mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 18 may 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 5/5/89 and/or this deed. | |
Breve descripción F/H land in the parishes of sevington & marshes ashford kent. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Second mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 18 may 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) to the chargee, under the terms of a facility letter dated 5/1/89 a mortgage dated 22/3/89 and this deed. | |
Breve descripción F/H land in the parishes of sevington & mersham ashford kent. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
First mortgage | Creado el 05 may 1989 Entregado el 18 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) to the chargee, under the terms of a facility letter dated 5/1/89 a mortgage dated 22/3/89 and this deed. | |
Breve descripción F/H land in the parishes of sevington & mersham ashford kent. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A first mortgage | Creado el 22 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and or this deed. | |
Breve descripción F/H land situate in the parishes of mersham sevinton of kingsnorth near ashford kent whole of land trnsferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD, by a transfer dated 22/03/89. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A second mortgage | Creado el 22 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and/or this deed | |
Breve descripción F/H land situate in the parish of mersham sevington & kingsnorth near ashford kent whole of land transferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD by a transfer dated 22/03/89. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A second mortgage | Creado el 22 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and/or this deed | |
Breve descripción F/H land situate in the parishes of mersham sevington & kingsnorth near ashford kent whole of land transferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD, by a transfer dated 22/03/89. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0