CEDARVALE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCEDARVALE
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02220037
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CEDARVALE?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra CEDARVALE?

    Dirección de la sede social
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDARVALE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PAYSYSTEM LIMITED10 feb 198810 feb 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDARVALE?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CEDARVALE?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta04 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence18 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta04 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDARVALE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Segunda presentación para el nombramiento de Neeta Shah como director

    3 páginasRP04AP01

    Nombramiento de Neeta Sha como director el 13 feb 2023

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    04 may 2023Clarification A second filed AP01 was registered on 04/05/2023.

    Cese del nombramiento de Tom Joy como director el 09 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Paul West como director el 10 oct 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Joanna Martha Henning como director el 12 mar 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Tom Joy como director el 12 mar 2020

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christopher Paul West como director el 23 may 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Joseph William Cannon como director el 23 may 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Nicola Ann Dymond como director el 06 ago 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Louis Carroll como director el 24 jul 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Louis Carroll como secretario el 24 jul 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de CEDARVALE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DYMOND, Nicola Ann
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritishGeneral Manager121493350002
    HENNING, Joanna Martha
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritishTown Planner268097060001
    JONES, Rosemarie Bernadette Katherine
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritishChartered Surveyor62743350006
    SHAH, Neeta
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritishHead Of Investment Accounting306569190001
    WEIR, John Charles
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritish,IrishChartered Surveyor And Town Planner176919900001
    BROOKE TURNER, James Evelyn
    6 Normanhurst Road
    SW2 3TA London
    Secretario
    6 Normanhurst Road
    SW2 3TA London
    British40055680001
    CANNON, Joseph William
    24 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    24 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    Australian32306440002
    CANNON, Joseph William
    31 Newport Road
    RH15 8QG Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    31 Newport Road
    RH15 8QG Burgess Hill
    West Sussex
    British32306440001
    CARROLL, Robert Louis
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Secretario
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    British54605410001
    HOPKINS, Colin Roy
    Flat I
    151 Plough Way
    SE16 1FN London
    Secretario
    Flat I
    151 Plough Way
    SE16 1FN London
    British47770940001
    MEGGS, Sandra Anne
    79 Queen Anne Avenue
    BR2 0SE Bromley
    Kent
    Secretario
    79 Queen Anne Avenue
    BR2 0SE Bromley
    Kent
    British11814610003
    ADAMS, Marian
    9 Birds Hill
    SG6 1PL Letchworth
    Hertfordshire
    Director
    9 Birds Hill
    SG6 1PL Letchworth
    Hertfordshire
    BritishHead Of Accounting Services48948570001
    BROWN, Andrew Charles
    The Croft 40 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    The Croft 40 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor40669790001
    CANNON, Joseph William
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    United KingdomAustralianSurveyor32306440002
    CARROLL, Robert Louis
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    United KingdomBritishProperty Tax Accountant54605410001
    CLARK, Paul Richard
    27 Latham Road
    TW1 1BN Twickenham
    Middlesex
    Director
    27 Latham Road
    TW1 1BN Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Surveyor94373770001
    DAWS, Christopher William
    27 Tufton Court
    Tufton Street
    SW1P 3QH London
    Director
    27 Tufton Court
    Tufton Street
    SW1P 3QH London
    EnglandBritishFinancial Secretary94373690001
    FARRELL, Michael Geoffrey Shaun
    7 Glenwood Close
    ME7 3RP Hempstead
    Kent
    Director
    7 Glenwood Close
    ME7 3RP Hempstead
    Kent
    BritishCommmercial Property Manager62415880001
    FENCHELLE, Mark Stephen
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    Director
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    BritishAccountant40682770001
    JOY, Tom
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    United KingdomBritishInvestment Director112820520001
    LINES, Robert John
    Ridge Langley
    CR2 0AS Sanderstead
    122
    Surrey
    Director
    Ridge Langley
    CR2 0AS Sanderstead
    122
    Surrey
    UkBritishAccountant152624080001
    LOCKE, Patrick
    1 Millbank
    SW1P 3JZ London
    Director
    1 Millbank
    SW1P 3JZ London
    BritishSecretary Church Commissioners7433200001
    NABARRO, Richard James
    37 Bosman Drive
    GU20 6JN Windlesham
    Surrey
    Director
    37 Bosman Drive
    GU20 6JN Windlesham
    Surrey
    BritishEcclesiastical Administrator40669860001
    TAYLERSON, Richard
    49 Dawnay Road
    KT23 4PE Great Bookham
    Surrey
    Director
    49 Dawnay Road
    KT23 4PE Great Bookham
    Surrey
    EnglandBritishSurveyor201599760001
    WEST, Christopher Paul
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    Director
    29 Great Smith Street
    London
    SW1P 3PS
    EnglandBritishChartered Surveyor164817570001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CEDARVALE?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cricklewood Trading Estates Limited
    Great Smith Street
    SW1P 3PS London
    29
    06 abr 2017
    Great Smith Street
    SW1P 3PS London
    29
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland & Wales Companies Register
    Número de registro00838703
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CEDARVALE alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 18 may 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 5/1/89, a mortgage dated 22/3/89 and this deed.
    Breve descripción
    F/H land in the parishes of sevirgton & mersham ashford kent.
    Personas con derecho
    • Imry Property Holdings PLC
    Transacciones
    • 18 may 1989Registro de una carga
    Second mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 18 may 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 5/5/89 and/or this deed.
    Breve descripción
    F/H land in the parishes of sevington & marshes ashford kent.
    Personas con derecho
    • Church Commissioner for England.
    Transacciones
    • 18 may 1989Registro de una carga
    Second mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 18 may 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) to the chargee, under the terms of a facility letter dated 5/1/89 a mortgage dated 22/3/89 and this deed.
    Breve descripción
    F/H land in the parishes of sevington & mersham ashford kent.
    Personas con derecho
    • Church Commissioners for England
    Transacciones
    • 18 may 1989Registro de una carga
    First mortgage
    Creado el 05 may 1989
    Entregado el 18 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) to the chargee, under the terms of a facility letter dated 5/1/89 a mortgage dated 22/3/89 and this deed.
    Breve descripción
    F/H land in the parishes of sevington & mersham ashford kent.
    Personas con derecho
    • Church Commissioners per England
    Transacciones
    • 18 may 1989Registro de una carga
    • 03 sept 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A first mortgage
    Creado el 22 mar 1989
    Entregado el 04 abr 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and or this deed.
    Breve descripción
    F/H land situate in the parishes of mersham sevinton of kingsnorth near ashford kent whole of land trnsferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD, by a transfer dated 22/03/89.
    Personas con derecho
    • Church Commissioners for England
    Transacciones
    • 04 abr 1989Registro de una carga
    A second mortgage
    Creado el 22 mar 1989
    Entregado el 04 abr 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and/or this deed
    Breve descripción
    F/H land situate in the parish of mersham sevington & kingsnorth near ashford kent whole of land transferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD by a transfer dated 22/03/89.
    Personas con derecho
    • Church Commissioners for England
    Transacciones
    • 04 abr 1989Registro de una carga
    A second mortgage
    Creado el 22 mar 1989
    Entregado el 04 abr 1989
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or ashford great park (phase I) limited under the facility letter dated 5.1.89 and/or this deed
    Breve descripción
    F/H land situate in the parishes of mersham sevington & kingsnorth near ashford kent whole of land transferred to the borrowers by ashford great park ( phase 1 ) LTD, by a transfer dated 22/03/89.
    Personas con derecho
    • Imry Property Holdings PLC.
    Transacciones
    • 04 abr 1989Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0