GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED

GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02220656
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Phoenix Building Central Boulevard
    Blythe Valley Park Shirley
    B90 8BG Solihull
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JBA SOFTWARE PRODUCTS LIMITED29 jul 199129 jul 1991
    OLYMPIC SOFTWARE LIMITED11 feb 198811 feb 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 31 may 2012

    2 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    2 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 mar 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de George Bisnought como director el 20 feb 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2011

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 ene 2012

    Estado de capital el 11 ene 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2010

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2009

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Comptes annuels modifiés établis au 31 may 2008

    9 páginasAAMD

    Cuentas preparadas hasta el 31 may 2008

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas preparadas hasta el 31 may 2007

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OLDROYD, Andrew
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish136724940001
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    Secretario
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    British140313340001
    DANIELS, Pascale Isabelle Denise Louise Marie Ghuislaine
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    Secretario
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    British86539580001
    DEANE, Keith
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British113569550001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Secretario
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    American112513570001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Secretario
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    American112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    Secretario
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    British33776800004
    SUTTON, Matthew Jeremy
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    Secretario
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    British92738100001
    TOWERS, Antony John
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    Secretario
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    British91463240002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    Secretario
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    British4180840002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    British101526370002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    British101526370002
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    Director
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    United KingdomBritish140313340001
    BRIDDON, Kenneth Carl
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    Director
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    British76868400001
    CULLENS, Alan Russell
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    Director
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    British99247410001
    FLEISCHER, Russell Lawrence
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    Director
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    United StatesAmerican154096470001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Director
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    United StatesAmerican112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    Director
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    British33776800004
    JONES, John Kevin
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    British68103800001
    JORDAN, Philip
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    Director
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    British51718170002
    KASPER, Jochen Berthold
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    Director
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    GermanyGerman113569900002
    KLINGWALL, Per Nils Christer
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    Swedish70508330002
    NEEMAN, Ellen
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    Director
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    Canadian70543520001
    NELSON, William George
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    Director
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    American50467760007
    ROSE, Malcolm James
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    Director
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    British21913860001
    SCIARD, Bertrand Andre Robert
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Director
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    French70543450001
    VICKERY, Alan Graham
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish4180850001
    WHEELER, Paul Michael
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish76692640002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    Director
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    EnglandBritish4180840002
    WRIGHT, Timothy John
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    Director
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    British97675480001

    ¿Tiene GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A loan,guaranty and security agreement
    Creado el 09 sept 2003
    Entregado el 18 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All loans,advances,debts, and principal due or to become due from the borrowers and duties of any kind due from the loan parties to the lender group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The amount paid to the company on account of any rights of suborgation the company may eequire under any loan document to which it is party; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Lender and the Collateral Agent
    Transacciones
    • 18 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An intercompany subordination agreement
    Creado el 09 sept 2003
    Entregado el 18 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness due or to become due from the borrowers to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any payment of any kind to any of the subordinated creditors on account of the subordinated indebtedness; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Senior Creditor and the Security Agent
    Transacciones
    • 18 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2001
    Entregado el 02 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies or liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the lenders (in such capacity the "agent") or any other loan party (as defined) (the "secured party") on any account whatsoever under pursuant to or in connection with the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ableco Finance Llc
    Transacciones
    • 02 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 18 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 dic 1999
    Entregado el 07 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant of the loan documents
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Toronto Dominion Bank
    Transacciones
    • 07 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 nov 1995
    Entregado el 21 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    Breve descripción
    "Eagle house" the slough studley warwickshire and the goodwill and connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 nov 1995
    Entregado el 21 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    Breve descripción
    "Needles house" birmingham road studley warwickshire and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 16 nov 1995
    Entregado el 21 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 21 mar 1994
    Entregado el 25 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 25 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 sept 1993
    Entregado el 05 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 oct 2012Fecha de disolución
    26 mar 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robin Arthur Ellis
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.
    Profesional
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0