SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED

SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02224895
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Maritime Centre
    Port Of Liverpool
    L21 1LA Liverpool
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SLATERSHELFCO 152 LIMITED26 feb 198826 feb 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 13 may 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 may 2016

    Estado de capital el 03 may 2016

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Thomas Eardley Allison como director el 29 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Whittaker como director el 29 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter John Hosker como director el 29 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Philip Wainscott como director el 29 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 abr 2015

    Estado de capital el 13 abr 2015

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr John Whittaker el 07 abr 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    2 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Peter John Hosker el 01 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Philip Wainscott el 27 ago 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 may 2014

    Estado de capital el 13 may 2014

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARRISON GILL, Caroline Ruth
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Secretario
    113 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DE Chester
    Woodleigh
    Cheshire
    Other140064590001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Holly Bank Drive
    HX3 8PA Halifax
    Woodcote
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165341530001
    WHITWORTH, Mark
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    Director
    Culvert Lane
    Off Back Lane
    WN8 7XA Newburgh
    Springside
    Lancashire
    EnglandBritish120679580002
    BOWLEY, William John
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    Secretario
    17 St Georges Road
    Formby
    L37 3HH Liverpool
    Merseyside
    British4171240002
    DICKINSON, Alan James
    Tasselrag Mill Lane
    Cuddington
    CW8 2TA Northwich
    Cheshire
    Secretario
    Tasselrag Mill Lane
    Cuddington
    CW8 2TA Northwich
    Cheshire
    British5937640001
    WAINSCOTT, Paul Philip
    The Squirrels
    7 Bolton Road Hawkshaw
    BL8 4HZ Bury
    Lancashire
    Secretario
    The Squirrels
    7 Bolton Road Hawkshaw
    BL8 4HZ Bury
    Lancashire
    British1549660002
    ALLISON, Thomas Eardley
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    Director
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Rockdale Lodge
    ScotlandBritish1037730004
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Director
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    BARR, Alan Andrew
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    Director
    7 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    Director
    Springkell Avenue
    Pollokshields
    G41 4EH Glasgow
    94
    United Kingdom
    ScotlandBritish86622660005
    BUTTERWORTH, Michael George
    4 Stoneleigh Gardens
    Grappenhall
    WA4 3LE Warrington
    Cheshire
    Director
    4 Stoneleigh Gardens
    Grappenhall
    WA4 3LE Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish48160080002
    GREEN, David Simon
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    Director
    16a Inverleith Row
    EH3 5LS Edinburgh
    British42038120003
    HILL, Martin Gerrard
    1 Edward Road
    Shaw
    OL2 7EZ Oldham
    Lancashire
    Director
    1 Edward Road
    Shaw
    OL2 7EZ Oldham
    Lancashire
    British2481240001
    HOSKER, Peter John
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Director
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    United KingdomBritish156229430001
    HOUGH, Robert Eric
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    Director
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritish38776360001
    HOWSON, William Geoffrey
    Rookery Farm Buxton Road
    CW12 2PN Congleton
    Cheshire
    Director
    Rookery Farm Buxton Road
    CW12 2PN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritish3599000002
    MORRIS, Geoffrey Ronald
    Whin Rigg Eccles Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6RS Stockport
    Cheshire
    Director
    Whin Rigg Eccles Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6RS Stockport
    Cheshire
    British3599010001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Director
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    British1674500002
    WAINSCOTT, Paul Philip
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Director
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    United KingdomBritish1549660002
    WHITTAKER, John
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Director
    The Trafford Centre
    M17 8PL Manchester
    Peel Dome
    England
    England
    Isle Of ManBritish1614010001

    ¿Tiene SHIP CANAL INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security deed of accession
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 13 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Secured Creditors
    Transacciones
    • 13 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 feb 2004
    Entregado el 02 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever,. By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First supplemental trust deed (supplemental to a trust deed dated 25TH november 1993)
    Creado el 31 mar 1994
    Entregado el 12 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys payable in respect of the £37,400,000 amortising bonds due 2014 of mscc to the chargee under the trust deed (as amended by the first supplemental trust deed) and for the performance of all other obligations (as defined) and the performance of all the company's obligations under its guarantee contained in the trust deed
    Breve descripción
    All rights,title,interest in and to all moneys receivable by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 12 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 09 dic 1993
    Entregado el 17 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land k/a units 1-6 200,210,220,500,560,300,310,320 and 400 being part of the land k/a land and buildings on the north east side of broadway tog with all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery the benefit of all contracts etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anz Grindlays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 25 nov 1993
    Entregado el 06 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to bankers trust company limited as trustee (as defined) in respect of the £37,400,000 amortising bonds due 2014 of mscc under the terms of the trust deed and all other moneys due or to become due from the issuer (as defined) any guarator or any charging subsidiary to the trustee and/or the bond holders (as defined) under the terms of the guarantee contained in the trust deed
    Breve descripción
    All the companys interests in and rrights and title to the non-core charged property including all rights title and interest in the headleases and the occupational leases and the proceeds of salee and an assignment of all the companys right title benefit and interest in and to all moneys receivable by the company or any sci successor charging subsidiary under any insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company Limitedas Trustee
    Transacciones
    • 06 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 may 1992
    Entregado el 07 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 16/10/89 as amended by a supplemental agreement dated 15/5/92
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Anz Grindlays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 oct 1989
    Entregado el 20 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan agreement dated 16-10-89 or the charge.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Grindlays Bank PLC.
    Transacciones
    • 20 oct 1989Registro de una carga
    • 22 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0