SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED

SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 02233737
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Couzens Building Apollo Buckingham Health Science Campus
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Cheshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CREWE DEVELOPMENT AGENCY LIMITED22 mar 198822 mar 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta26 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence09 ago 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta26 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    10 páginasAA

    Nombramiento de Miss Katie Vost como director el 04 dic 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert Stanley Parton como director el 26 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Lois Wright como director el 26 sept 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Timothy Butler como director el 16 dic 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Andrew John Wood como director el 16 dic 2021

    2 páginasAP01

    Notification de South Cheshire Chamber of Commerce & Industry Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov 2021

    1 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov 2021

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael John Wright como director el 29 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael John Wright como director el 07 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew John Wood como director el 07 oct 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Morris como director el 07 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Mrs Madeleine Lisa Abbey el 07 oct 2020

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Christopher Paul Colman el 07 oct 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 022337370003

    4 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    9 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABBEY, Madeleine Lisa
    Apollo Buckingham Health Science Campus
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    England
    Secretario
    Apollo Buckingham Health Science Campus
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    England
    211223190001
    COLMAN, Christopher Paul
    Apollo Buckingham Health Science Campus
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    England
    Director
    Apollo Buckingham Health Science Campus
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    England
    EnglandBritishChief Executive168454690002
    MORRIS, David
    Electra Way
    CW1 6ZF Crewe
    Banks Sheridan, Datum House
    England
    Director
    Electra Way
    CW1 6ZF Crewe
    Banks Sheridan, Datum House
    England
    United KingdomBritishAccountant275102670001
    PARTON, Robert Stanley
    Church Minshull
    CW5 6DX Nantwich
    Church Minshull Marina
    England
    Director
    Church Minshull
    CW5 6DX Nantwich
    Church Minshull Marina
    England
    EnglandBritishManaging Director126377440001
    VOST, Katie
    Weston Road
    CW1 6FL Crewe
    Weston Centre Business Hub
    England
    Director
    Weston Road
    CW1 6FL Crewe
    Weston Centre Business Hub
    England
    EnglandBritishManaging Director330056640001
    WOOD, Andrew John
    Weston Road
    CW1 6FL Crewe
    Wr Estates Ltd, Weston Centre
    England
    Director
    Weston Road
    CW1 6FL Crewe
    Wr Estates Ltd, Weston Centre
    England
    United KingdomBritishManaging Director101522920002
    BARNES, Jonathan Lee
    Westmere Drive
    Crewe Business Park
    CW1 6ZD Crewe
    Lyme Building
    England
    Secretario
    Westmere Drive
    Crewe Business Park
    CW1 6ZD Crewe
    Lyme Building
    England
    178975540001
    COLMAN, Christopher Paul
    24 Browning Close
    Ettiley Heath
    CW11 3ZH Sandbach
    Cheshire
    Secretario
    24 Browning Close
    Ettiley Heath
    CW11 3ZH Sandbach
    Cheshire
    British75805910002
    DUNNING, John
    40 Hellath Wen
    CW5 7BB Nantwich
    Cheshire
    Secretario
    40 Hellath Wen
    CW5 7BB Nantwich
    Cheshire
    British18035550001
    BARKER, John Granville
    Oakdene Kidderton Lane
    Burland
    CW5 8JD Nantwich
    Cheshire
    Director
    Oakdene Kidderton Lane
    Burland
    CW5 8JD Nantwich
    Cheshire
    BritishFinance Director37953300001
    BROSCOME, Ian
    S C O P E Scope House
    Weston Road
    CW1 1DD Crewe
    Cheshire
    Director
    S C O P E Scope House
    Weston Road
    CW1 1DD Crewe
    Cheshire
    BritishDirector13106960001
    BUTLER, Andrew Timothy
    Hospital Street
    CW5 5RL Nantwich
    Legat Owen, Nantwich Court
    Cheshire
    England
    Director
    Hospital Street
    CW5 5RL Nantwich
    Legat Owen, Nantwich Court
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector Commercial Estate Agents109651310002
    BUTTERILL, Douglas Neville
    21 Birchin Lane
    CW5 6JU Nantwich
    Cheshire
    Director
    21 Birchin Lane
    CW5 6JU Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishLandscape Gardener43908380002
    COLLINS, David John, Dr
    Chapel Cottage
    Ashfield, Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    Director
    Chapel Cottage
    Ashfield, Leigh Sinton
    WR13 5DH Malvern
    EnglandBritishPrincipal111378700001
    COOPER, James
    30 Bowness Road
    Wistaston
    CW2 8RN Crewe
    Cheshire
    Director
    30 Bowness Road
    Wistaston
    CW2 8RN Crewe
    Cheshire
    British13106970001
    CROWE, James Henry
    Uplands
    10a Fonnereau Road
    IP1 3JP Ipswich
    Suffolk
    Director
    Uplands
    10a Fonnereau Road
    IP1 3JP Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishRetired7087170001
    CUTLER, Keith James
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor - Advocate107116600001
    DAVIES, Robin
    South Cheshire College
    Dane Bank Avenue
    CW2 8AB Crewe
    Cheshire
    Director
    South Cheshire College
    Dane Bank Avenue
    CW2 8AB Crewe
    Cheshire
    BritishPrincipal13106980001
    DUNNING, John
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive18035550001
    FOSTER, Betty
    Manor Way
    CW2 6PH Crewe
    245
    England
    Director
    Manor Way
    CW2 6PH Crewe
    245
    England
    EnglandBritishEngineer48776650001
    FOSTER, Betty
    245 Manor Way
    CW2 6PH Crewe
    Cheshire
    Director
    245 Manor Way
    CW2 6PH Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director48776650001
    GILLIS, Richard
    Thatched Cottage
    Shirley
    DE6 3AS Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Thatched Cottage
    Shirley
    DE6 3AS Ashbourne
    Derbyshire
    BritishSolicitor6060300002
    GORMLEY, Andrew Geoffrey
    19 Cherry Tree Close
    Hilton
    DE65 5FD Derby
    Derbyshire
    Director
    19 Cherry Tree Close
    Hilton
    DE65 5FD Derby
    Derbyshire
    BritishGeneral Manager42479640001
    GRANGE, Patrick Voller Beeston
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Couzens Buildingmanchester Metropolitan University
    Crewe Green Rd
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant83111310003
    GRAY, Andrew
    British Rail Engineering Ltd Gower Street
    DE1 1AH Derby
    Derbyshire
    Director
    British Rail Engineering Ltd Gower Street
    DE1 1AH Derby
    Derbyshire
    BritishManager13106990001
    HARDING, Mark John
    3 Westmere Close
    Weston
    CW2 5LT Crewe
    Cheshire
    Director
    3 Westmere Close
    Weston
    CW2 5LT Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishPlant Manager110828670001
    HINDS, Frank
    Wellcome Foundation Ltd Weston Road
    CW1 1UB Crewe
    Cheshire
    Director
    Wellcome Foundation Ltd Weston Road
    CW1 1UB Crewe
    Cheshire
    BritishHead Of Uk Commercial Division13107000001
    JONES, Peter, Professor
    156 Manor Way
    CW2 6JY Crewe
    Cheshire
    Director
    156 Manor Way
    CW2 6JY Crewe
    Cheshire
    BritishUniversity Professor47324630001
    LEECE, David, Professor
    10 The Glade
    Westbury Park Clayton
    ST5 4NG Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    10 The Glade
    Westbury Park Clayton
    ST5 4NG Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishHigher Education113042720001
    LOWE, David William
    38 Springbourne
    Frodsham
    WA6 6QD Warrington
    Cheshire
    Director
    38 Springbourne
    Frodsham
    WA6 6QD Warrington
    Cheshire
    BritishBank Manager33627900001
    MATHER, Roger
    Crewe & Nantwich Borough Council
    Municipal Buildings Earle Street
    CW1 2BJ Crewe
    Cheshire
    Director
    Crewe & Nantwich Borough Council
    Municipal Buildings Earle Street
    CW1 2BJ Crewe
    Cheshire
    BritishChief Executive51330280001
    MATTHEWS, Charles
    Rolls Royce Motor Cars
    Pyms Lane
    Crewe
    Cheshire
    Director
    Rolls Royce Motor Cars
    Pyms Lane
    Crewe
    Cheshire
    BritishDirector13107020001
    MORAN, Arthur
    Bowater Security Printers
    Frances Street
    CW2 6HG Crewe
    Cheshire
    Director
    Bowater Security Printers
    Frances Street
    CW2 6HG Crewe
    Cheshire
    BritishManaging Director50390560001
    NEWTON, David John
    16 Meadow Close
    Shavington
    CW2 5BE Crewe
    Cheshire
    Director
    16 Meadow Close
    Shavington
    CW2 5BE Crewe
    Cheshire
    BritishUniversity Lecturer29908250002
    NUTTER, David
    Yorkshire Bank Plc Victoria Street
    CW1 2LH Crewe
    Cheshire
    Director
    Yorkshire Bank Plc Victoria Street
    CW1 2LH Crewe
    Cheshire
    BritishBank Manager13107040001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    South Cheshire Chamber Of Commerce & Industry Ltd
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    England
    23 nov 2021
    Crewe Green Road
    CW1 5DU Crewe
    Couzens Building
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Guarantee
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SOUTH CHESHIRE CHAMBER PROPERTY LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    29 jul 201623 nov 2021La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0