DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02236715
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FORD HOUSE LIMITED21 jun 198821 jun 1988
    CHARTCLIMB LIMITED28 mar 198828 mar 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    6 páginasSH20

    Estado de capital el 05 ene 2015

    • Capital: GBP 320.44
    4 páginasSH19

    legacy

    6 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction in additional paid in capital 14/12/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 nov 2014

    Estado de capital el 17 nov 2014

    • Capital: GBP 320.44
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 oct 2013

    Estado de capital el 16 oct 2013

    • Capital: GBP 320.44
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Dan Steven Agan como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Carlan Cooper como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Norman Tommy Barras como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert Theron Brockman como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Terry Wallace Jones como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert Maxey Nalley como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Moss como director

    1 páginasTM01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 oct 2010

    • Capital: GBP 320.44
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 oct 2010

    • Capital: GBP 320.43
    3 páginasSH01

    ¿Quiénes son los directivos de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Secretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    AGAN, Dan Steven
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053880001
    BARRAS, Norman Tommy
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053860001
    BROCKMAN, Robert Theron
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican158497330001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Director
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    COOPER, Carlan Max
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    UsaUnited States136536270001
    JONES, Terry Wallace
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053830001
    NALLEY, Robert Maxey
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Director
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053700001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Secretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Secretario
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    ARROWSMITH, Robert George
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    Director
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    United KingdomBritish70780350004
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Director
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Director
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritish89866330001
    FABRE, Jeremie
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    Director
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    French116364550001
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish64591610001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Director
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    British94654870001
    MERRIMAN, Christopher Peter
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    Director
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    British63578740002
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Director
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    ROBINSON, Timothy Michael
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Director
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritish154155330001
    RUFF, David Hessel
    36 Oakford Drive
    Allesley
    CV5 7PP Coventry
    West Midlands
    Director
    36 Oakford Drive
    Allesley
    CV5 7PP Coventry
    West Midlands
    United KingdomBritish23232440001
    SOANES, David
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    Director
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    British80021380001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Director
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    British46677090001
    STERKENBURG, Daniel Richard
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    Director
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    American116364510001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Director
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish42686850001

    ¿Tiene DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 12 mar 2004
    Entregado el 01 abr 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2004Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 05 jun 2000
    Entregado el 13 jun 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2000Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 07 nov 1997
    Entregado el 18 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 mar 1993
    Entregado el 16 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0