DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02236715 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FORD HOUSE LIMITED | 21 jun 1988 | 21 jun 1988 |
| CHARTCLIMB LIMITED | 28 mar 1988 | 28 mar 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 6 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 05 ene 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 6 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dan Steven Agan como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Carlan Cooper como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Norman Tommy Barras como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Theron Brockman como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Terry Wallace Jones como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Maxey Nalley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Moss como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 oct 2010
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 oct 2010
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSS, Michael Craig | Secretario | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | American | 121496770001 | ||||||
| AGAN, Dan Steven | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | 84053880001 | |||||
| BARRAS, Norman Tommy | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | 84053860001 | |||||
| BROCKMAN, Robert Theron | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | 158497330001 | |||||
| BURNETT, Robert David | Director | Post Oak Run 77355 Magnolia 28122 Texas Usa | United States | American | 121495910001 | |||||
| COOPER, Carlan Max | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | Usa | United States | 136536270001 | |||||
| JONES, Terry Wallace | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | 84053830001 | |||||
| NALLEY, Robert Maxey | Director | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | 84053700001 | |||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Secretario | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Secretario | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Secretario | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | British | 89866330001 | ||||||
| ROGERS, Wendy Fiona | Secretario | Fulbrook House 14 West End HP22 5TT Weston Turville Buckinghamshire | British | 72773920003 | ||||||
| ARROWSMITH, Robert George | Director | 8 Brendon Drive KT10 9EQ Esher | United Kingdom | British | 70780350004 | |||||
| BROMLEY, Christopher Philip | Director | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | 112670520001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Stephen | Director | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | United Kingdom | British | 89866330001 | |||||
| FABRE, Jeremie | Director | 4 Rue Du Lac Messery 74140 France | French | 116364550001 | ||||||
| FORSYTH, Andrew James | Director | Well House Farm Pateley Bridge HG3 5NG Harrogate North Yorkshire | England | British | 64591610001 | |||||
| GUJRAL, Ben | Director | Churchfield Lodge Churchfield Path EN8 9EG Cheshunt Hertfordshire | British | 94654870001 | ||||||
| MERRIMAN, Christopher Peter | Director | 1 Oakdene Drive Barnt Green B45 8LQ Birmingham West Midlands | British | 63578740002 | ||||||
| MOSS, Michael Craig | Director | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | United States | American | 121496770001 | |||||
| ROBINSON, Timothy Michael | Director | Wells Farmhouse OX44 7PP Little Milton Oxfordshire | England | British | 154155330001 | |||||
| RUFF, David Hessel | Director | 36 Oakford Drive Allesley CV5 7PP Coventry West Midlands | United Kingdom | British | 23232440001 | |||||
| SOANES, David | Director | Fencewood House Slanting Hill RG18 9QQ Cold Ash Berkshire | British | 80021380001 | ||||||
| SPENCE, Raymond Leslie | Director | 1 Mill Lane WS14 0DP Lichfield Staffordshire | British | 46677090001 | ||||||
| STERKENBURG, Daniel Richard | Director | Rue De L'Eglise 7 Crans-Pres-Celigny 1299 Switzerland | American | 116364510001 | ||||||
| YAPP, Stephen | Director | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | 42686850001 |
¿Tiene DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 12 mar 2004 Entregado el 01 abr 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 05 jun 2000 Entregado el 13 jun 2000 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 07 nov 1997 Entregado el 18 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 mar 1993 Entregado el 16 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0