TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02236859 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
- Otras actividades de servicios de reserva n.c.p. (79909) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Dirección de la sede social | Axis One Axis Park 10 Hurricane Way SL3 8AG Langley Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HOTELZON UK LIMITED | 27 mar 2006 | 27 mar 2006 |
HOTELINE LIMITED | 28 mar 1988 | 28 mar 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jan Daniel Guillou como director el 07 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 20 sept 2019
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 sept 2019
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Jason Robert Clarke como director el 20 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Niklas Gunnar Andreen como director el 20 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Modification des détails de Travelport Hotelzon International (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Jonathan Stark como secretario el 13 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Jonathan Stark como secretario el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr. Jan Daniel Guillou como director el 17 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Axis One Axis Park 10 Hurricane Way Langley Berkshire SL3 8AG | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENMAN, Helen | Secretario | Axis Park 10 Hurricane Way SL3 8AG Langley Axis One Berkshire United Kingdom | 193690840001 | |||||||
CLARKE, Jason Robert | Director | Axis Park 10 Hurricane Way SL3 8AG Langley Axis One Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 163354650002 | ||||
DAWSON, Jayne | Secretario | Cherry Trees Main Road Itchen Abbas SO21 1AT Winchester Hampshire | British | 63044610002 | ||||||
KASKINEN, Jani Miikka Tapani | Secretario | Heron Square TW9 1EP Richmond Hill House Surrey | Finnish | Vice President | 135974190004 | |||||
KORPPI-TOMMOLA, Juha | Secretario | 02700 Kauniainen Kirkkotie 10 D Finland | Finnish | 128502090001 | ||||||
MACOMISH, John | Secretario | Nuthatch Cottage Higher Coombses TA20 2SY Chard Somerset | British | Director | 109942540001 | |||||
MARCHANT, Maria | Secretario | 5 Kew Road TW9 2PR Richmond Parkshot House Surrey England | 188580060001 | |||||||
MORLEY, Mike, Vice President | Secretario | 5 Kew Road TW9 2PR Richmond Parkshot House Surrey England | 170942990002 | |||||||
NEWCOMBE, Philip | Secretario | Grange Barn Marston Lane LE16 9SL East Farndon Leics | British | 122400270001 | ||||||
PAINTER, Deborah Jayne | Secretario | Heron Square TW9 1EP Richmond Hill House Surrey | British | 168512890001 | ||||||
STARK, Gavin Jonathan | Secretario | Axis Park 10 Hurricane Way SL3 8AG Langley Axis One Berkshire | 205354830001 | |||||||
ANDREEN, Niklas Gunnar | Director | 11348 Stockholm Surbrunnsgatan 50, 5tr Sweden | Sweden | Swedish | Gvp Hospitality & Partner Marketing | 188588130001 | ||||
DAWSON, Barrie William | Director | Cherry Trees Main Road Itchen Abbas SO21 1AT Winchester Hampshire | British | Manager | 63044650001 | |||||
DAWSON, Jayne | Director | Cherry Trees Main Road Itchen Abbas SO21 1AT Winchester Hampshire | British | Director | 63044610002 | |||||
FLOMAN, Erik Jarl Richard | Director | 26 Lupus Street SW1V 3DZ London | Finnish | Director | 111282200001 | |||||
GUILLOU, Jan Daniel, Mr. | Director | 02230 Espoo Linnoitustie 4a Finland | Finland | Finnish | Managing Director | 201620530001 | ||||
HUUMONEN, Ismo Antti | Director | 5 Kew Road TW9 2PR Richmond Parkshot House Surrey England | Finland | Finnish | Cfo | 111282370002 | ||||
KASKINEN, Jani Miikka Tapani | Director | 5 Kew Road TW9 2PR Richmond Parkshot House Surrey England | Finland | Finnish | Ceo | 135974190004 | ||||
MACOMISH, John | Director | Nuthatch Cottage Higher Coombses TA20 2SY Chard Somerset | British | Director | 109942540001 | |||||
NEWCOMBE, Philip | Director | Grange Barn Marston Lane LE16 9SL East Farndon Leics | British | Travel Industry | 122400270001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travelport Hotelzon International (Uk) Limited | 06 abr 2016 | 10 Hurricane Way SL3 8AG Langley, Berkshire Axis One, Axis Park United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene TRAVELPORT HOTELZON UK LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creado el 08 jun 2009 Entregado el 12 jun 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción With full title guarantee the initial rent deposit paid under the terms of the rent deposit deed being £11,500.00 relating to the property k/a 3RD floor 39A southgate street winchester hampshire see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 oct 2006 Entregado el 02 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 08 abr 2005 Entregado el 15 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,500 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The designated deposit account opened by the chargees in which they have placed the deposit. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 24 dic 1999 Entregado el 11 ene 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease of even date | |
Breve descripción The deposit account in which the initial deposit of £1,500 has been placed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0