MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED

MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02240236
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2016 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Richard John Harwin como director el 13 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 022402360008

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Mbm Secretarial Services Limited como secretario el 30 abr 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2015

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mr Andrew Peter Jones el 01 nov 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Andrew Peter Jones el 01 nov 2015

    2 páginasCH01

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 26 jul 2015

    19 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 ago 2015

    Estado de capital el 20 ago 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    capital20 ago 2015

    Estado de capital el 14 sept 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 sept 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 14/09/2015.

    Nombramiento de Mbm Secretarial Services Limited como secretario el 03 ago 2015

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Frank Carl Straetmans como director el 13 may 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Herring Lawson como director el 13 may 2015

    1 páginasTM01

    Modificación de la carga 022402360009, creada el 10 jun 2015

    15 páginasMR07

    Registro de la carga 022402360009, creada el 10 jun 2015

    25 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Andrew Peter
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    Secretario
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    182346500001
    ASHTON, Stephen Richard
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Director
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    ScotlandBritish198382800001
    HOUSTOUN, Alexander
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Director
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    United KingdomBritish13350630001
    JONES, Andrew Peter
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    Director
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    EnglandBritish181551660001
    SYMON, Alan Wilson
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Director
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    ScotlandBritish115942360001
    HILL, Ewan
    21b Exchange Street
    DD1 3DJ Dundee
    Angus
    Secretario
    21b Exchange Street
    DD1 3DJ Dundee
    Angus
    British123402720001
    HOLLAND, Carol
    The Willows 18 Lucan Close
    Sibsey
    PE22 0SH Boston
    Lincolnshire
    Secretario
    The Willows 18 Lucan Close
    Sibsey
    PE22 0SH Boston
    Lincolnshire
    British14187890002
    MORGAN, Andrew
    Newton Road
    DD7 6HQ Carnoustie
    37
    Angus
    Secretario
    Newton Road
    DD7 6HQ Carnoustie
    37
    Angus
    British146653900001
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Secretario
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    British112021460001
    CCW SECRETARIES LIMITED
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Fife
    Secretario corporativo
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Fife
    63577400019
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC156630
    133157900001
    BROWN, Matthew Jeremy
    Fuller Street
    CM3 2AY Fairstead
    2 White Cottages
    Essex
    Director
    Fuller Street
    CM3 2AY Fairstead
    2 White Cottages
    Essex
    EnglandBritish108565950004
    HARWIN, Richard John
    Platts Lane
    Bucknall
    LN10 5DY Woodhall Spa
    White Cottage
    Lincolnshire
    Director
    Platts Lane
    Bucknall
    LN10 5DY Woodhall Spa
    White Cottage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish132931070001
    LAWSON, Richard Herring
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    Director
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    ScotlandBritish146501290001
    LAWSON, Richard Fraser
    Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    39a
    United Kingdom
    Director
    Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    39a
    United Kingdom
    ScotlandBritish110947350003
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Director
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritish112021460001
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Director
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritish112021460001
    STRAETMANS, Frank Carl
    Springfield Road
    CM2 6AS Chelmsford
    272
    Essex
    England
    Director
    Springfield Road
    CM2 6AS Chelmsford
    272
    Essex
    England
    United KingdomBelgian148283530002
    WALKER, Rodney Jon Ogden
    Granary House Boothby
    Graffoe
    LN5 0LE Lincoln
    Lincolnshire
    Director
    Granary House Boothby
    Graffoe
    LN5 0LE Lincoln
    Lincolnshire
    British39016650001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Andrew Peter Jones
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    06 abr 2016
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 10 jun 2015
    Entregado el 25 jun 2015
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 25 jun 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 jul 2015Particularidades de un instrumento de alteración de un cargo (MR07)
    A registered charge
    Creado el 15 may 2015
    Entregado el 29 may 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Maven Capital Partners UK LLP (As Security Trustee for and on Behalf of Scottish Loan Fund L.P.)
    Transacciones
    • 29 may 2015Registro de una carga (MR01)
    • 09 jun 2015Particularidades de un instrumento de alteración de un cargo (MR07)
    • 14 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 24 nov 2005
    Entregado el 08 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Factory premises at roughton road kirby on bain lincolnshire t/no LL81623. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 10 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 10 oct 2005
    Entregado el 26 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 26 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 28 feb 1994
    Entregado el 09 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land and buildings at roughton road kirkby-on-bain nr. Woodhall spa lincolnshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 jun 1992
    Entregado el 09 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Goodwill uncalled capital patents patent applications copyrights trade names trade marks.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 01 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 08 mar 1989
    Entregado el 10 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 1989Registro de una carga
    • 01 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0