TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02243256 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KIER HOMES CALEDONIA LIMITED | 24 oct 2008 | 24 oct 2008 |
| KIER HOMES LIMITED | 01 may 1998 | 01 may 1998 |
| TWIGDEN HOMES MIDLANDS LIMITED | 03 jun 1988 | 03 jun 1988 |
| LOOKSTAKE LIMITED | 11 abr 1988 | 11 abr 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Daniel Stewart Wilson como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU United Kingdom a Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park Solihull B90 8AU el 14 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mamunur Rahman como director el 15 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian John Mitchell como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2024 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 71 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Trevor David Thomas como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gareth Russell Jacob como director el 13 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Jonathan Hiles como director el 30 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 jun 2023 au 31 mar 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Stewart Wilson como secretario el 31 may 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Modification des détails de Tilia Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE United Kingdom a Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU el 16 ago 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Bosley Phillips como director el 15 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Tilia Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 jun 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILES, James Jonathan | Director | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 265522960001 | |||||
| JACOB, Gareth Russell | Director | Central Boulevard Shirley B90 8AU Solihull Tungsten Building England | England | British | 303523150001 | |||||
| RAHMAN, Mamunur | Director | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 323769010001 | |||||
| ARMITAGE, Matthew | Secretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 193475380001 | |||||||
| BRAND, Duncan Valentine | Secretario | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | British | 16800690001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Secretario | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GREGORY, Robert William | Secretario | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | British | 109817750001 | ||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Secretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | British | 116752570006 | ||||||
| HIGGINS, Philip | Secretario | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | 262491930001 | |||||||
| KANE, Paul Edward | Secretario | 48 Katewell Avenue Drumchapel G15 8ER Glasgow Lanarkshire Scotland | British | 88265100001 | ||||||
| MCCOLL, Mary Jean | Secretario | Keysoe Lodge Keysoe Row West MK44 2JF Keysoe Bedfordshire | British | 34757030001 | ||||||
| MCDONAGH, Stuart Ali | Secretario | 19 Greek Thomson Road Balfron G63 0RE Glasgow Lanarkshire | British | 117628720001 | ||||||
| MELGES, Bethan | Secretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199691300001 | |||||||
| TWIGDEN, David Robert | Secretario | 21 Duloe Road St Neots PE19 4HW Huntingdon Cambridgeshire | British | 37904870001 | ||||||
| WILSON, Daniel Stewart | Secretario | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | 299160360001 | |||||||
| AITCHISON, Andrew William | Director | 9 Finlayson Place FK5 4FX Larbert Stirlingshire | United Kingdom | British | 104820240002 | |||||
| ANDERSON, John Bruce | Director | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 29878320002 | |||||
| BRAND, Duncan Valentine | Director | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 16800690001 | |||||
| BROOMFIELD, Matthew | Director | 11 Centenary Road Brampton PE28 4YQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 108705890001 | ||||||
| BROWNE, Daniel Harry Rate | Director | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 154494390001 | |||||
| COOPER, Sarah Jayne | Director | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 188395230001 | |||||
| COPE, David | Director | 7 Castle Gardens Ballikinrain G63 0LT Glasgow Strathclyde | British | 68139500002 | ||||||
| CREMIN, Theresa Bernadette | Director | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 185269400001 | |||||
| DUFFY, Allan | Director | 11 Tollhouse Way Girdle Toll KA11 1RB Irvine Ayrshire | British | 68139530001 | ||||||
| FERGUSON, Isabella | Director | 22 Chelmsford Drive G12 0NA Glasgow | United Kingdom | British | 116248510002 | |||||
| GALLOWAY, Bryan Thomas | Director | 31 Bellefield Crescent ML11 7QY Lanark Lanarkshire | British | 122141580001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Director | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GORDON-STEWART, Alastair James | Director | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 124512200002 | |||||
| GREGORY, Robert William | Director | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| GREGORY, Robert William | Director | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| HOLDOM, Denise Ivy | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Lysander House Bedfordshire | England | British | 116935560002 | |||||
| HOMER, David | Director | 28 Eastwood Drive Highwoods CO4 4EB Colchester Essex | British | 16658920001 | ||||||
| HOPE, Lorna Jane | Director | 35 Cameron Street KY12 8DP Dunfermline Fife | British | 82965270001 | ||||||
| KANE, Paul Edward | Director | 48 Katewell Avenue Drumchapel G15 8ER Glasgow Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 88265100001 | |||||
| KING, Christopher | Director | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 81798580013 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia Homes Limited | 06 abr 2016 | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0