ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD

ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02244781
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    Dirección de la sede social
    440-450 Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GAMECHAMP ENTERPRISES LIMITED15 abr 198815 abr 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta26 feb 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Mark Derrick Beacham como secretario el 03 feb 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Julia Reynolds como director el 03 feb 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director el 03 feb 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Derrick Beacham como director el 03 feb 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Marcello Lombardo como director el 16 dic 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director el 21 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2011

    5 páginasAA

    Nombramiento de Ms Julia Reynolds como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 15 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2011

    Estado de capital el 15 jun 2011

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Richard Hitt como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Derrick Beacham como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 feb 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    10 páginasMG01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cambio de datos del secretario Mr Mark Derrick Beacham el 01 oct 2009

    3 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Marcello Lombardo el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Richard John Hitt el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    39 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Section 175
    RES13

    Cuentas preparadas hasta el 28 feb 2009

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Secretario
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    British135313320001
    BENNETT, Terry
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    Secretario
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    British135196530001
    DAWSON, Mary Louise
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    Secretario
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    British68983920002
    HOLDSWORTH, Cheryl Irene
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British48354260001
    MURRAY, Philip John
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    Secretario
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    British79329620001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Secretario
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Secretario
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Other79416150001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    Secretario
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    British87465680001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    Secretario
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    British2545190001
    AYNSLEY, Martin Arthur
    83 Ravenscroft
    CW4 7HJ Holmes Chapel
    Cheshire
    Director
    83 Ravenscroft
    CW4 7HJ Holmes Chapel
    Cheshire
    British50712720001
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Director
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    United KingdomBritish160095260001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Director
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritish3007630001
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Director
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    British30882970002
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Director
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish112723440002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Director
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Director
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritish96458190001
    HESLOP, Russell David
    82 Portland Crescent
    Belvidere
    SY2 5NW Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    82 Portland Crescent
    Belvidere
    SY2 5NW Shrewsbury
    Shropshire
    British15527530001
    HIBBARD, Alison Maria
    77 Windmill Drive
    Croxley Green
    WD3 3FB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    77 Windmill Drive
    Croxley Green
    WD3 3FB Rickmansworth
    Hertfordshire
    British38380910001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Director
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    United KingdomBritish127468180001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Director
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    United KingdomBritish137285750001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Director
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    EnglandBritish135699240001
    MALONE, Desmond Philip
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    Director
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish87170450001
    REYNOLDS, Julia
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Director
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    EnglandBritish127468460001
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish124619670001
    SPURLING, Anthony James
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    British5224490001
    WALKER, Graeme
    3 Carrock Close
    Oakerside Park
    SR8 1EE Peterlee
    County Durham
    Director
    3 Carrock Close
    Oakerside Park
    SR8 1EE Peterlee
    County Durham
    British57477120001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish2545190001

    ¿Tiene ALL AMERICAN FOOTWEAR CORPORATION LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of accession
    Creado el 18 nov 2009
    Entregado el 23 nov 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creado el 07 dic 1999
    Entregado el 14 dic 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities ( whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 dic 1999Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 25 jul 1996
    Entregado el 08 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from blacks leisure group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a unit 2 northumberland way stephenson industrial estate washington tyne & wear t/n TY244423 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over deposit
    Creado el 21 may 1993
    Entregado el 02 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies from time to time standing to the company's account with the bank please see form 395 M42 for full details.
    Personas con derecho
    • Mees Pierson N.V.
    Transacciones
    • 02 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 dic 1990
    Entregado el 04 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See doc for full details) (M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank Mees & Hope Nv
    Transacciones
    • 04 ene 1991Registro de una carga
    • 31 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of resale contracts for goods
    Creado el 30 oct 1990
    Entregado el 08 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title and interest in any contract please see 395 for full details.
    Personas con derecho
    • I B Finance (UK) PLC
    Transacciones
    • 08 nov 1990Registro de una carga
    • 09 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 oct 1990
    Entregado el 08 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital.
    Personas con derecho
    • I B Finance (UK) PLC.
    Transacciones
    • 08 nov 1990Registro de una carga
    • 10 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 sept 1990
    Entregado el 11 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 2 stephenson industrial estate washington, tyne & wear.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 1990Registro de una carga
    • 09 nov 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 nov 1989
    Entregado el 28 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Stocks, shares, bonds and securities.
    Personas con derecho
    • D. Q. Henriques Limited
    Transacciones
    • 28 nov 1989Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 03 abr 1989
    Entregado el 11 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 1989Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0