ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED

ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENTERPRISE INFORMATICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02253256
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    • (7221) /
    • (7222) /

    ¿Dónde se encuentra ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Old Bridge House
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Middlesex
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPESCOM SOFTWARE LIMITED14 ago 200114 ago 2001
    SPESCOM KMS LIMITED16 ene 200116 ene 2001
    ALTRIS GROUP PLC22 nov 199622 nov 1996
    TRIMCO GROUP PLC26 jun 199126 jun 1991
    TRIMCO ENTERPRISES PLC13 jun 199113 jun 1991
    TRIMCO ENTERPRISES LIMITED09 may 198809 may 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 feb 2011

    Estado de capital el 15 feb 2011

    • Capital: GBP 406,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Richard Lee Shorten como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Low como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martin O'riley como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Kiraly como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cambio de datos del director Alan Philip Kiraly el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Martin Dominic O Riley el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director John Low el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cambio de datos del director Mr Barry Timothy Fitzmaurice el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Barry Timothy Fitzmaurice el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2008

    16 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    16 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZMAURICE, Barry Timothy
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    British52690920001
    FITZMAURICE, Barry Timothy
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish52690920002
    SHORTEN, Richard Lee
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    UsaAmerican152520290001
    ATKINSON, Martin Peter
    17 Dornden Drive
    Langton Green
    TN3 0AA Tunbridge Wells
    Kent
    Secretario
    17 Dornden Drive
    Langton Green
    TN3 0AA Tunbridge Wells
    Kent
    British64484640001
    BANTIN, David
    36 Ashley Drive
    TW2 6HW Twickenham
    Secretario
    36 Ashley Drive
    TW2 6HW Twickenham
    British40585410002
    FITZMAURICE, Barry Timothy
    10 Ormsby Gardens
    UB6 9NR Greenford
    Middlesex
    Secretario
    10 Ormsby Gardens
    UB6 9NR Greenford
    Middlesex
    British52690920001
    KNIGHT, John Anthony
    7 Brendon Close
    KT10 9EH Esher
    Surrey
    Secretario
    7 Brendon Close
    KT10 9EH Esher
    Surrey
    British11822540001
    PATEL, Jayendrakumar Naginbhai, Mr.
    16 Melbourne Road
    TW11 9QX Teddington
    Middlesex
    Secretario
    16 Melbourne Road
    TW11 9QX Teddington
    Middlesex
    British117610640001
    BANTIN, David
    36 Ashley Drive
    TW2 6HW Twickenham
    Director
    36 Ashley Drive
    TW2 6HW Twickenham
    British40585410002
    BLAGDEN, Simon Paul
    The Old Rectory Church Road
    IP30 9AL Beyton
    Suffolk
    Director
    The Old Rectory Church Road
    IP30 9AL Beyton
    Suffolk
    British57130990001
    BRADY, Peter J J
    11704 Great Owl Circle
    Reston
    20194 Virginia
    America
    Director
    11704 Great Owl Circle
    Reston
    20194 Virginia
    America
    American62228530001
    ERICKSON, Roger
    114 Cleveland Ct
    93003 Ventura
    Calfornia
    Usa
    Director
    114 Cleveland Ct
    93003 Ventura
    Calfornia
    Usa
    Usa64483380001
    FARAH, Anthony
    Ville 21 Sandhurst Estate
    Empire Place
    2196 Sandton
    Guateng
    South Africa
    Director
    Ville 21 Sandhurst Estate
    Empire Place
    2196 Sandton
    Guateng
    South Africa
    South African64483900001
    KIRALY, Alan Philip
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    UsaUsa125199810001
    KNIGHT, John Anthony
    7 Brendon Close
    KT10 9EH Esher
    Surrey
    Director
    7 Brendon Close
    KT10 9EH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish11822540001
    LEITNER, Johann Robert
    11956 Mil Pitero Road
    FOREIGN San Diego
    92128 California
    Usa
    Director
    11956 Mil Pitero Road
    FOREIGN San Diego
    92128 California
    Usa
    South African86088140001
    LIDDELL, Robert Edward
    3 Vernon Road
    Bushey
    WD2 2JL Watford
    Hertfordshire
    Director
    3 Vernon Road
    Bushey
    WD2 2JL Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish196978920001
    LOW, John
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    UsaAmerican60071940001
    MARTIN, Bernard William
    Heatherbrae
    Firwood Rise
    TN21 8NP Heathfield
    East Sussex
    Director
    Heatherbrae
    Firwood Rise
    TN21 8NP Heathfield
    East Sussex
    United KingdomBritish32375080003
    O'RILEY, Martin Dominic
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    40 Church Street
    TW18 4EP Staines
    Old Bridge House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish153601770001
    PATEL, Jayendrakumar Naginbhai, Mr.
    16 Melbourne Road
    TW11 9QX Teddington
    Middlesex
    Director
    16 Melbourne Road
    TW11 9QX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish117610640001
    STENTIFORD, Keith
    315 Sneath Way 315 Sneath Way
    Alpine
    CA 91901 California
    Usa
    Director
    315 Sneath Way 315 Sneath Way
    Alpine
    CA 91901 California
    Usa
    South African108590440001
    TANNA, Jayantilal Velji
    Trimithia Gardens
    PO BOX 60483
    8103 Paphos
    8103
    Cyprus
    Director
    Trimithia Gardens
    PO BOX 60483
    8103 Paphos
    8103
    Cyprus
    British63020350002
    TANNA, Sunil Jay
    10 Willow Court
    Corney Reach
    W4 2TW Chiswick
    London
    Director
    10 Willow Court
    Corney Reach
    W4 2TW Chiswick
    London
    British59130660001
    TURNER, William Alan
    8 Gordon Place
    Tarves
    AB41 0NW Ellon
    Aberdeenshire
    Director
    8 Gordon Place
    Tarves
    AB41 0NW Ellon
    Aberdeenshire
    British18996320002
    UPSDELL, Robert Stanley
    Dragon Wyck
    Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Bucks
    Director
    Dragon Wyck
    Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Bucks
    British36094270002
    VAN NIEKERK, Denton
    Sodbury House
    7 Chaucer Grove
    GU15 2XZ Camberley
    Surrey
    Director
    Sodbury House
    7 Chaucer Grove
    GU15 2XZ Camberley
    Surrey
    British27158010001
    WRIGHT, Timothy Arthur
    4 Munnery Way
    BR6 8QD Orpington
    Kent
    Director
    4 Munnery Way
    BR6 8QD Orpington
    Kent
    United KingdomBritish46706440001

    ¿Tiene ENTERPRISE INFORMATICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 nov 1988
    Entregado el 25 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery stock in trade, work in progress pre-payments investment.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 25 nov 1988Registro de una carga
    • 15 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 22 ago 1988
    Entregado el 12 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1988Registro de una carga
    • 01 may 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0