BMBF (NO.12) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBMBF (NO.12) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02259175
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BMBF (NO.12) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BMBF (NO.12) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BMBF (NO.12) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 1 Churchill Place London E14 5HP a Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshawe Manchester M23 9JA

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de , 1 Churchill Place, London, E14 5HP, England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 16 may 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 abr 2017

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 1 Churchill Place London E14 5HP

    1 páginasAD04

    Domicilio social registrado cambiado de , Churchill Plaza, Churchill Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 7GP a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 19 sept 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    28 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 jun 2016

    Estado de capital el 24 jun 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nombramiento de Mr Vukkalam Rangaswami Praveen Kumar como director el 20 may 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ketan Dhirendra Merchant como director el 16 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Terence Leather como director el 23 nov 2015

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    34 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ketan Dhirendra Merchant como director el 12 ago 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ago 2015

    Estado de capital el 12 ago 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 may 2015

    Estado de capital el 12 may 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    32 páginasAA

    Nombramiento de David Charles Hawkins como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 may 2014

    Estado de capital el 16 may 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Andrew Asquith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Andrew Martin Granville Asquith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Duncan Rowberry como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretario corporativo
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    BOLTON, Stephen Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish177906520001
    HAWKINS, David Charles
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish188138870001
    KUMAR, Vukkalam Rangaswami Praveen
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian207316480001
    OTTAWAY, Angela Nicole
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169152200001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    ABLITT, Denis Raymond
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British71782000001
    ASQUITH, Andrew Martin Granville
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish77784310001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Director
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Director
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CALVERT, Ashley
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish166501700001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Director
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Director
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HASSELL, Brian Charles
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish45384250002
    HILLS, Richard Allan
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Director
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish71778800001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Director
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MARCHANT, Jeremy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish154144600001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MERCHANT, Ketan Dhirendra
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian200060960001
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Director
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Director
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Director
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Director
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06 abr 2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro898129
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BMBF (NO.12) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A first preferred vanuatu ship mortgage
    Creado el 16 abr 2004
    Entregado el 26 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in and to the vessel. (Motor vessel 'gsf jack ryan' registered under the vanuatu flag with official number 1561). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Globalsantafe International Drilling Corporation
    Transacciones
    • 26 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Account assignment schedule no:52/5050 5371-3
    Creado el 22 ene 2001
    Entregado el 25 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The obligations of the company to make payment to the chargee of any and all moneys by way of rebate of rental in accordance with clauses 10.2 and 20.2 of the lease (as defined)
    Breve descripción
    The account which means the account of the company withe the account bank with account number 10353817 and designated "global marine inc.,glomar jack ryan" and the amount standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transacciones
    • 25 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    First preferred panamanian naval mortgage
    Creado el 26 oct 2000
    Entregado el 10 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee to effect a transfer of title to the vessel being the M.V. "glomar jack ryan" under any sale contract entered into in accordance with clause 19.2 of the head lease being a lease agreement dated 8TH december 1998 between the company and chargee in respect of the vessel and all moneys by way of rebate of rental under clause 20.2 of said head lease
    Breve descripción
    All the company's right title benefit and interest in and to the vessel in accordance with the provisions of chapter v title iv of book second of the code of commerce of the republic of panama.
    Personas con derecho
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transacciones
    • 10 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Secondary lease security assignment
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from i/s oktober-gruppen and /or kim F. rasmussen under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Breve descripción
    All th elessees right title interest in and to the assigned payments.see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sublessee security agreement
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 14 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated and the head lease both dated 24/11/92
    Breve descripción
    All rights title interest in and to the head lease and head security agreement.see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transacciones
    • 14 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BMBF (NO.12) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2
    FechaTipo
    27 abr 2017Inicio de la liquidación
    22 nov 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0