CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02262027 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Hackwood Secretaries Limited One Silk Street EC2Y 8HQ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED | 17 ene 1996 | 17 ene 1996 |
| CIN INVESTORS NOMINEES LIMITED | 06 abr 1990 | 06 abr 1990 |
| CIN INVESTORS (NOMINEES) LIMITED | 07 jul 1988 | 07 jul 1988 |
| CERTAINPROMPT LIMITED | 25 may 1988 | 25 may 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kevin John Whale como director el 17 feb 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Nicholas Rowlands como director el 22 mar 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Guy Bryce Davison como director el 17 feb 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hugh Macgillivray Langmuir como director el 17 feb 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 11 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Broadwalk House 5 Appold Street London EC2A 2HA el 10 may 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Hugh Macgillivray Langmuir el 06 dic 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Hugh Macgillivray Langmuir el 06 dic 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Simon Nicholas Rowlands el 04 nov 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Simon Nicholas Rowlands el 04 nov 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Guy Bryce Davison el 04 nov 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Guy Bryce Davison el 04 nov 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 11 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Andrew Colato como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew Neville Joy el 14 may 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Cowling como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew Neville Joy el 25 nov 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robin Alexander Hall el 30 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHALE, Kevin John | Secretario | 51 Guilford Avenue KT5 8DG Surbiton Surrey | British | 46925320002 | ||||||
| COLATO, Michael Andrew | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | United Kingdom | British | 154132900001 | |||||
| HALL, Robin Alexander | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7AG London Cinven United Kingdom | United Kingdom | British | 35549940003 | |||||
| JOY, Andrew Neville | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | England | British | 44663290001 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Director | Warwick Court Paternoster Square EC4M 7AG London Cinven United Kingdom | England | British | 36233000004 | |||||
| WHALE, Kevin John | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | United Kingdom | British | 46925320002 | |||||
| BURGESS, Mark Geoffrey William | Secretario | 5 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | 28476620004 | ||||||
| CARSLAW, Iain Alexander | Secretario | 4 Woodvale Avenue Giffnock G46 6RQ Glasgow | British | 31798100001 | ||||||
| LEVINGS, Alan Clifford | Secretario | 8 Rookswood Close RG27 9EU Hook Hampshire | British | 123716400001 | ||||||
| BROWN, John Forster | Director | 7 Hurst Avenue N6 5TX London | United Kingdom | British | 4183480002 | |||||
| BURGESS, Mark Geoffrey William | Director | 5 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | 28476620004 | ||||||
| CARSLAW, Iain Alexander | Director | 4 Woodvale Avenue Giffnock G46 6RQ Glasgow | British | 31798100001 | ||||||
| CHOTAI, Yagnish Vrajlal | Director | Whitebeams 1 Hanyards Lane, Cuffley EN6 4AS Potters Bar Hertfordshire | England | British | 17626330003 | |||||
| CLARKE, Jonathan George Gough | Director | Logmore Place Logmore Lane RH4 3JN Westcott Surrey | United Kingdom | British | 72712910003 | |||||
| COWLING, David Wren | Director | York House Berners Street W1T 3LG London Flat 21 | British | 109432930002 | ||||||
| DAVISON, Guy Bryce | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | England | British | 48717030003 | |||||
| KENISTON-COOPER, Graham James | Director | 17 Ovington Square SW3 1LH London | England | British | 73698890002 | |||||
| LANGMUIR, Hugh Macgillivray | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | England | British,French | 42365820007 | |||||
| MARCHANT, Andrew William | Director | Pitch Place Farm Thursley GU8 6QW Godalming Surrey | British | 10380660001 | ||||||
| MASKELL, Philip John | Director | 1 Grange Cottages Broad Common Road RG10 0RD Hurst Berkshire | British | 5733160002 | ||||||
| MUNTON, Richard James | Director | The Grange Grange Hill TN15 0RG Plaxtol Kent | British | 11882410016 | ||||||
| NICHOLSON, Charles Dumaresq | Director | 20 Brook Green W6 7BL London | England | British | 141669020001 | |||||
| ROWLANDS, Simon Nicholas | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court United Kingdom | United Kingdom | British | 40561640003 | |||||
| WHEELER, Nigel Brentwood | Director | 101 College Road Dulwich SE21 7HN London | British | 13339750004 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0