CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED

CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02262027
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED17 ene 199617 ene 1996
    CIN INVESTORS NOMINEES LIMITED06 abr 199006 abr 1990
    CIN INVESTORS (NOMINEES) LIMITED07 jul 198807 jul 1988
    CERTAINPROMPT LIMITED25 may 198825 may 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2012

    Estado de capital el 12 oct 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Kevin John Whale como director el 17 feb 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Simon Nicholas Rowlands como director el 22 mar 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Guy Bryce Davison como director el 17 feb 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hugh Macgillivray Langmuir como director el 17 feb 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    11 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Broadwalk House 5 Appold Street London EC2A 2HA el 10 may 2011

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Hugh Macgillivray Langmuir el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Hugh Macgillivray Langmuir el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Simon Nicholas Rowlands el 04 nov 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Simon Nicholas Rowlands el 04 nov 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Guy Bryce Davison el 04 nov 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Guy Bryce Davison el 04 nov 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    11 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Michael Andrew Colato como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Andrew Neville Joy el 14 may 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de David Cowling como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Andrew Neville Joy el 25 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Robin Alexander Hall el 30 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CINVEN INVESTORS NOMINEES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WHALE, Kevin John
    51 Guilford Avenue
    KT5 8DG Surbiton
    Surrey
    Secretario
    51 Guilford Avenue
    KT5 8DG Surbiton
    Surrey
    British46925320002
    COLATO, Michael Andrew
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish154132900001
    HALL, Robin Alexander
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Cinven
    United Kingdom
    Director
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Cinven
    United Kingdom
    United KingdomBritish35549940003
    JOY, Andrew Neville
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    EnglandBritish44663290001
    LINDEN, Brian Andrew
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Cinven
    United Kingdom
    Director
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Cinven
    United Kingdom
    EnglandBritish36233000004
    WHALE, Kevin John
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish46925320002
    BURGESS, Mark Geoffrey William
    5 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    Secretario
    5 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    British28476620004
    CARSLAW, Iain Alexander
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Secretario
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    British31798100001
    LEVINGS, Alan Clifford
    8 Rookswood Close
    RG27 9EU Hook
    Hampshire
    Secretario
    8 Rookswood Close
    RG27 9EU Hook
    Hampshire
    British123716400001
    BROWN, John Forster
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    Director
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    United KingdomBritish4183480002
    BURGESS, Mark Geoffrey William
    5 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    Director
    5 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    British28476620004
    CARSLAW, Iain Alexander
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Director
    4 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    British31798100001
    CHOTAI, Yagnish Vrajlal
    Whitebeams
    1 Hanyards Lane, Cuffley
    EN6 4AS Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    Whitebeams
    1 Hanyards Lane, Cuffley
    EN6 4AS Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish17626330003
    CLARKE, Jonathan George Gough
    Logmore Place
    Logmore Lane
    RH4 3JN Westcott
    Surrey
    Director
    Logmore Place
    Logmore Lane
    RH4 3JN Westcott
    Surrey
    United KingdomBritish72712910003
    COWLING, David Wren
    York House
    Berners Street
    W1T 3LG London
    Flat 21
    Director
    York House
    Berners Street
    W1T 3LG London
    Flat 21
    British109432930002
    DAVISON, Guy Bryce
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    EnglandBritish48717030003
    KENISTON-COOPER, Graham James
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    Director
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    EnglandBritish73698890002
    LANGMUIR, Hugh Macgillivray
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    EnglandBritish,French42365820007
    MARCHANT, Andrew William
    Pitch Place Farm
    Thursley
    GU8 6QW Godalming
    Surrey
    Director
    Pitch Place Farm
    Thursley
    GU8 6QW Godalming
    Surrey
    British10380660001
    MASKELL, Philip John
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    Director
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    British5733160002
    MUNTON, Richard James
    The Grange
    Grange Hill
    TN15 0RG Plaxtol
    Kent
    Director
    The Grange
    Grange Hill
    TN15 0RG Plaxtol
    Kent
    British11882410016
    NICHOLSON, Charles Dumaresq
    20 Brook Green
    W6 7BL London
    Director
    20 Brook Green
    W6 7BL London
    EnglandBritish141669020001
    ROWLANDS, Simon Nicholas
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Director
    Paternoster Square
    EC4M 7AG London
    Warwick Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish40561640003
    WHEELER, Nigel Brentwood
    101 College Road
    Dulwich
    SE21 7HN London
    Director
    101 College Road
    Dulwich
    SE21 7HN London
    British13339750004

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0