WRC P.L.C.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWRC P.L.C.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02262098
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WRC P.L.C.?

    • Otras actividades de ingeniería (71129) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra WRC P.L.C.?

    Dirección de la sede social
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WRC P.L.C.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WATER RESEARCH CENTRE (1989) PUBLIC LIMITED COMPANY01 mar 198901 mar 1989
    JOSAD LIMITED25 may 198825 may 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WRC P.L.C.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WRC P.L.C.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    25 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    24 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    21 páginasAM10

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA/AM02SOC

    14 páginasAM02

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de la propuesta del administrador

    32 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de Frankland Road Blagrove Swindon Wiltshire SN5 8YF a 25 Moorgate London EC2R 6AY el 19 sept 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Cese del nombramiento de Martin Frederick Bradbury como director el 22 ene 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2019 con actualizaciones

    15 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2019

    38 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Martin Frederick Bradbury el 04 oct 2018

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2018 con actualizaciones

    15 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Martin Frederick Bradbury como director el 19 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2018

    38 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Jayne Elizabeth Matwiejczyk como secretario el 11 jul 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Patricia Lorraine Williams como secretario el 10 jul 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Martin Wayne Baggs como director el 08 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    2 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Anthony Kerr Griffiths como director el 17 abr 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de WRC P.L.C.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MATWIEJCZYK, Jayne Elizabeth
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    Secretario
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    248645070001
    CHAPMAN, Ronald Eric
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    Director
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    EnglandBritishDirector23664410001
    HOME, Sonia Margaret
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    Director
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United KingdomBritishChief Executive108533050001
    SMITH, Mark William
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    Director
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United KingdomIrishDirector159144150001
    GRIFFITHS, Anthony
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Frankland House
    Wiltshire
    Uk
    Secretario
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Frankland House
    Wiltshire
    Uk
    British159144940001
    HALDER, Alan Kenneth, Dr
    Old Farm
    Bulls Head Green
    GU6 7PB Ewhurst
    Surrey
    Secretario
    Old Farm
    Bulls Head Green
    GU6 7PB Ewhurst
    Surrey
    BritishFinance Director13717000002
    MCLINTOCK, Karen Aileen
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    British32112690001
    WILLIAMS, Patricia Lorraine
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    240756540001
    BAGGS, Martin Wayne
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Director
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector234081230001
    BRADBURY, Martin Frederick
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Director
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector153279520001
    CUCCIA, Paolo
    Piazzale Ostiense 2
    Rome
    00154
    Italy
    Director
    Piazzale Ostiense 2
    Rome
    00154
    Italy
    ItalianCeo67996860002
    FIELD, David Bruce
    23 Eastfield
    Ashton Keynes
    SN6 6PR Swindon
    Wiltshire
    Director
    23 Eastfield
    Ashton Keynes
    SN6 6PR Swindon
    Wiltshire
    BritishExecutive Director15146310001
    GRIFFITHS, Anthony Kerr
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Director
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritishFinance Director87392510001
    HALDER, Alan Kenneth, Dr
    Old Farm
    Bulls Head Green
    GU6 7PB Ewhurst
    Surrey
    Director
    Old Farm
    Bulls Head Green
    GU6 7PB Ewhurst
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director13717000002
    HENDERSON, Bernard Vere
    Cornishes Cottages
    Bag Lane Fryerning
    CM4 0NR Ingatestone
    Essex
    Director
    Cornishes Cottages
    Bag Lane Fryerning
    CM4 0NR Ingatestone
    Essex
    BritishChairman Anglian Water Plc2156120001
    HODGE, Ralph Noel
    Anstye Place
    Anstye
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Anstye Place
    Anstye
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector37679770001
    JEFFERY, Jack
    High Pines 19 The Avenue
    Chobham
    GU24 8RU Woking
    Surrey
    Director
    High Pines 19 The Avenue
    Chobham
    GU24 8RU Woking
    Surrey
    BritishChairman45716750001
    MANGANO, Andrea
    Viaticino 7
    FOREIGN 00198 Rome
    Italy
    Director
    Viaticino 7
    FOREIGN 00198 Rome
    Italy
    ItalianDirector77050650001
    MERRILL JR, John P
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Director
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    UsaUsInt'L Developer58708730002
    MOSS, John, Doctor
    Yew Tree Cottage Catslip
    Nettlebed
    RG9 5BN Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Yew Tree Cottage Catslip
    Nettlebed
    RG9 5BN Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishNon Executive Director35879110001
    PALMER, Keith Francis, Dr
    32 Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    Director
    32 Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    United KingdomBritishMerchant Banker32840370001
    ROUSE, Michael John
    96 Lonsdale Road
    OX2 7ER Oxford
    Oxfordshire
    Director
    96 Lonsdale Road
    OX2 7ER Oxford
    Oxfordshire
    BritishManaging Director32564730001
    SADLER, John Stephen
    7 The Chilterns
    63 Chiltern Street
    W1M 1HS London
    Director
    7 The Chilterns
    63 Chiltern Street
    W1M 1HS London
    BritishCompany Director39060560001
    STEWART, William Duncan Paterson, Sir
    45 Fairfield Road
    Broughty Ferry
    DD5 1PL Dundee
    Director
    45 Fairfield Road
    Broughty Ferry
    DD5 1PL Dundee
    BritishConsultant44404530003
    VARINI, Stefano Bruno, Doctor
    Rione Sirigndno 7
    Naples
    80121
    Italy
    Director
    Rione Sirigndno 7
    Naples
    80121
    Italy
    ItalianC.P.A72953790001
    ZOCCHI, Roberto
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    Director
    Frankland Road
    Blagrove
    SN5 8YF Swindon
    Wiltshire
    ItalyItalianDirector94687310001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para WRC P.L.C.?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    28 sept 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene WRC P.L.C. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 31 ago 2017
    Entregado el 15 sept 2017
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Associated Employers Trustee Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 15 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 31 ago 2017
    Entregado el 15 sept 2017
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Associated Employers Trustee Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 15 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    Legal charge
    Creado el 06 jun 2011
    Entregado el 16 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the water associated employer's pension scheme on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land on the east side of frankland road blagrove swindon together with all buildings and fixtures by way of assignment the proceeds of any sale lease sublease assignment or transfer or any agreement see image for full details.
    Personas con derecho
    • Associated Employers Trustee Limited (As Trustee of the Water Associated Employer's Pension Scheme)
    Transacciones
    • 16 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 20 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 27 jul 2000
    Entregado el 29 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Site g frankland road blagrove swindon wiltshire (freehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 20 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattels mortgage
    Creado el 04 feb 1999
    Entregado el 04 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The equipment specified in the schedule to the deed being as follows 2 x pii pc with serial no. FR83618459 & FR83729512, 13 x 78.2 GB low-proflie hot swap untra 2 scsi, 2 x hp netserver with serial no's;-FR83619871 & FR83710082 1 x dlt library (US7A500175) 1 x hp server (FR83710083) 9 x hp laserjet (nlqb 003923/008863) (nlrb 027984/028087/016215/015847/016281/016276/016236), 9 x hp laserjet 8000/2000 sheet input (serial no's as above) 12 x hp laserjet 4000 tn printer 12 x laserjet 4000 duplex paper feeder with serial numbers (nlew 325327, 325798, 325352,325797,325855,235238) (nley 005487, 005482, 003932,005472,005486) (nlew 327401). x hp deskjet 1600 cm printer (USB8604146) and 1 x hp network scanjet 5 ethernet (ITL8182005). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 04 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 02 oct 1998
    Entregado el 02 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 new perkin elmer elan 6000 inductively coupled plasma mass spectrometer and all ancillary items serial no's;-4049709 3664 and 3552. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Limited
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 02 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 26 jun 1995
    Entregado el 08 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 31ST march 1989
    Breve descripción
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 1989
    Entregado el 10 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of clause 3.1 on an acquisition agreement dated 31 march 1989
    Breve descripción
    F/H land and buildings at henley road medmenham near marlow in the county of buckinghamshire having an area of approx 23 acres l/h land and buildings situate at site "g" blagrove farm near swindon in the county of wiltshire having an area of approx 12.17 acres title no WT38674.
    Personas con derecho
    • Water Research Centre
    Transacciones
    • 10 abr 1989Registro de una carga
    • 19 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 31 mar 1989
    Entregado el 10 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1989Registro de una carga
    • 20 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 1989
    Entregado el 10 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings at henley road medmenham near marlow, buckinghamshire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1989Registro de una carga
    • 29 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 1989
    Entregado el 10 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land and buildings situate at site "9" blagrove farm near swindon wiltshire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1989Registro de una carga
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WRC P.L.C. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 ago 2020Inicio de la administración
    18 ene 2022Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Adam Henry Stephens
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Profesional
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Andrew Stephen Mcgill
    3rd Floor, 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    Profesional
    3rd Floor, 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0