PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED

PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02263711
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    • Transporte aéreo de pasajeros no programado (51102) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Recovery House Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MCALPINE AVIATION SERVICES LIMITED29 ene 199929 ene 1999
    OPERATIONAL SUPPORT SERVICES LIMITED19 oct 198919 oct 1989
    RAPID 6177 LIMITED01 jun 198801 jun 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    15 páginasLIQ14
    A8ILBIMY

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 mar 2016

    10 páginasLIQ03
    A882YIQ3

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 mar 2019

    13 páginasLIQ03
    A82JVRMG

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 mar 2018

    11 páginasLIQ03
    A7AY0HFP

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 mar 2017

    11 páginasLIQ03
    A7AY0HF5

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    10 páginas4.20
    A43XN996

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600
    A43XN98Q

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 11 mar 2015

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de Business Aviation Centre Blackbushe Airport, Camberley Surrey GU17 9LG a Recovery House Roebuck Road Hainault Business Park Ilford Essex IG6 3TU el 30 jul 2014

    1 páginasAD01
    X3D6TN6R

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    20 páginasAA
    A3AFCD14

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ene 2014

    Estado de capital el 22 ene 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01
    X304P7V5

    Nombramiento de Mr Alan Peter Howard como secretario

    2 páginasAP03
    X304NU68

    Cese del nombramiento de Gd Secretarial Services Limited como secretario

    1 páginasTM02
    X304NU2J

    Cancelación total de la carga 022637110011

    1 páginasMR04
    X304NFQ3

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 ene 2013 au 30 jun 2013

    1 páginasAA01
    X2FN1DQO

    Registro de la carga 022637110011

    26 páginasMR01
    A2ASPVOB

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    20 páginasAA
    L29UZGXS

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X227BMXM

    Domicilio social registrado cambiado de * Business Aviation Centre Blackbushe Airport Camberley Surrey GU17 9LG England* el 14 feb 2013

    1 páginasAD01
    X227BMXE

    Domicilio social registrado cambiado de * Recovery House Roebuck Road, Hainault Business Park Ilford Essex IG6 3TU England* el 14 feb 2013

    1 páginasAD01
    X227BHEJ

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2012 au 31 ene 2013

    1 páginasAA01
    X20P175K

    Nombramiento de Mr Graham Avery como director

    3 páginasAP01
    A1MMUKXE

    ¿Quiénes son los directivos de PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWARD, Alan Peter
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    Secretario
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    184458810001
    AVERY, Graham
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    Director
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    EnglandBritishNone71863630005
    HOWARD, Alan Peter
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    Director
    Roebuck Road
    Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    England
    EnglandBritishNone92755830001
    AMOS, Eric William
    72 The Avenue
    HA5 5BJ Pinner
    Middlesex
    Secretario
    72 The Avenue
    HA5 5BJ Pinner
    Middlesex
    British6171490001
    BLAKELEY, Andrew Marcus
    10 Salford Road
    Marston
    OX3 0RX Oxford
    Secretario
    10 Salford Road
    Marston
    OX3 0RX Oxford
    BritishCompany Secretary42194160001
    COWEN, Brendon Raymond
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary1234020001
    HILL, Robert Colin
    18 Hanstone Close
    Cranham Park
    GL7 1WX Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    18 Hanstone Close
    Cranham Park
    GL7 1WX Cirencester
    Gloucestershire
    British48146530001
    WALKER, Robert Peter
    30 The Copse
    Fields End
    HP1 2TA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    30 The Copse
    Fields End
    HP1 2TA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11492400001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    10 St Bride Street
    EC4A 4AD London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    10 St Bride Street
    EC4A 4AD London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02471626
    66216820001
    BOLT, Andrew Reginald
    The Rowans
    11 Peakshill
    CR8 3JG Purley
    Surrey
    Director
    The Rowans
    11 Peakshill
    CR8 3JG Purley
    Surrey
    EnglandBritishConstruction & Property63420900001
    BUDDEN, Derek Ernest Arthur
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    Director
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    BritishChartered Accountant605520001
    BUDDEN, Derek Ernest Arthur
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    Director
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    BritishChartered Accountant605520001
    DAVIS, Andrew
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    Director
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishDirector77124350001
    FORREST, Christopher Anthony Alexander
    The Malt Shovel Lavender Square
    OX18 2LR Bampton
    Oxfordshire
    Director
    The Malt Shovel Lavender Square
    OX18 2LR Bampton
    Oxfordshire
    EnglandBritishOperations Director50405970001
    HARDING, Michael Howard
    10 St Bride Street
    EC4A 4AD London
    Fifth Floor
    Director
    10 St Bride Street
    EC4A 4AD London
    Fifth Floor
    United KingdomBritishFinancial Director91348520001
    MCALPINE, James Thomas Hemery
    Hamilton House
    Charney Road,Longworth
    OX13 5HW Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Hamilton House
    Charney Road,Longworth
    OX13 5HW Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishHelicopter Pilot10866490002
    MCALPINE, Kenneth
    The Priory
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    Director
    The Priory
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    United KingdomBritishCivil Engineering And Building153526290002
    MCROBERT, David Malcolm
    Hamilton House
    Abingdon Road
    OX29 7QH Standlake
    Oxon
    Director
    Hamilton House
    Abingdon Road
    OX29 7QH Standlake
    Oxon
    United KingdomBritishManaging Director81722830001
    REVEILLON, Gilbert
    62 Gresham Road
    TW3 4BU Hounslow
    Middlesex
    Director
    62 Gresham Road
    TW3 4BU Hounslow
    Middlesex
    BritishManaging Director45761140001
    SOMERVILLE, Robert Merrett
    29 Cassel Avenue
    BH13 6JD Poole
    Dorset
    Director
    29 Cassel Avenue
    BH13 6JD Poole
    Dorset
    EnglandBritishCommercial Director67753560001
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant1604580001
    WOOLF, Robert Anthony
    2 Berkeley Road
    Barnes
    SW13 9LZ London
    Director
    2 Berkeley Road
    Barnes
    SW13 9LZ London
    EnglandBritishChartered Accountant5215540002

    ¿Tiene PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2013
    Entregado el 18 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 18 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 22 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 nov 2012
    Entregado el 01 dic 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Pcc Int'l LTD
    Transacciones
    • 01 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    Deed of admission
    Creado el 31 oct 2011
    Entregado el 08 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from or by any one or more of the existing companies or the further company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The credit balances see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 27 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 09 sept 2008
    Entregado el 10 sept 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 sept 2008Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 sept 2008
    Entregado el 10 sept 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 sept 2008Registro de un cargo (395)
    • 16 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 mar 2007
    Entregado el 23 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    The aircraft mortgage
    Creado el 01 mar 2004
    Entregado el 06 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    AS355F1 ifr, registration mark: g-bxbt, serial number:5262 as more particulary described in the mortgage as the aircraft including the engines and all equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transacciones
    • 06 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    The aircraft mortgage
    Creado el 01 mar 2004
    Entregado el 06 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    AS355F1 ifr, registration mark: zh 141, serial number: 5327 more particulary described in the mortgage as the aircraft including the engines as described in the mortgage and all equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transacciones
    • 06 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 03/11/95
    Creado el 22 ago 2002
    Entregado el 04 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 04 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 29 abr 1994
    Entregado el 17 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    And amending a composite guarantee and debenture dated 30TH april 1993
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 17 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 abr 1993
    Entregado el 06 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of "the facilities" (as defined) or this charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 06 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PREMIAIR AVIATION SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 feb 2020Fecha de disolución
    11 mar 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Alan John Clark
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    Profesional
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0