ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED

ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02284553
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    • Otros transportes terrestres de pasajeros urbano, suburbano o metropolitano (no metro ni sistemas similares) (49319) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    YORKSHIRE WOOLLEN DISTRICT TRANSPORT COMPANY LIMITED25 oct 198825 oct 1988
    SIMCO 246 LIMITED05 ago 198805 ago 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG el 14 mar 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 feb 2017

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Cocker como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Lorna Edwards como director el 27 jun 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nigel Paul Featham como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 may 2016

    Estado de capital el 03 may 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 22 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 may 2015

    Estado de capital el 05 may 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2014

    Estado de capital el 06 may 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nombramiento de Mrs Lorna Edwards como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Elizabeth Davies como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    19 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Richard Anthony Bowler el 16 ago 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    19 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 26 may 2012

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Secretario
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183720710001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Director
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritish205425080001
    COCKER, David
    49 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    49 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    British37574310001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Secretario
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    British13774020001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    ADCOCK, Paul
    1 Field View
    Cawston
    CV22 7FE Rugby
    Warwickshire
    Director
    1 Field View
    Cawston
    CV22 7FE Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish112858780001
    BARFOOT, Vernon
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    Director
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    British89516570001
    BARKER, Neil James
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    Director
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    EnglandBritish165014000001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOOKER, Philip Geoffrey
    22 Naseby Road
    DE56 0ER Belper
    Derbyshire
    Director
    22 Naseby Road
    DE56 0ER Belper
    Derbyshire
    British84332090001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish35116070003
    BOWLER, Richard Charles
    25 Rock Farm Lane
    Sandford On Thames
    OX4 4YL Oxford
    Director
    25 Rock Farm Lane
    Sandford On Thames
    OX4 4YL Oxford
    British51739150002
    CLARKE, Kenneth Barry
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    British76952760002
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Director
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    COCKER, David
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish37574310001
    CUMMINS, Philip
    7 Marina Avenue
    Sutton
    WA9 3TA St Helens
    Merseyside
    Director
    7 Marina Avenue
    Sutton
    WA9 3TA St Helens
    Merseyside
    United KingdomBritish153482060001
    DAVIES, Justin Wyn
    7 Hawkenbury Road
    TN2 5BN Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    7 Hawkenbury Road
    TN2 5BN Tunbridge Wells
    Kent
    British66657430002
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    FLYNN, James Sidney
    4 Milnthorpe Drive
    Sandal
    WF2 7HU Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    4 Milnthorpe Drive
    Sandal
    WF2 7HU Wakefield
    West Yorkshire
    Irish77440240001
    HARVEY, Peter
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    Director
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish30318040003
    HODGSON, Kenneth
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    Director
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    United KingdomBritish9946200002
    HOSKINS, Neil Terence
    45 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    45 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    West Yorkshire
    British14322510001
    HUNTER, Michael John
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    British1058260002
    JACKSON, Brian Malcolm
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    British90088220001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Director
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Director
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    United KingdomBritish13774020001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Director
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Director
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    ROBERTS, Ralph Robert
    46 Jackson Drive
    Crowwod Grange
    G33 6GF Stepps
    Lanarkshire
    Director
    46 Jackson Drive
    Crowwod Grange
    G33 6GF Stepps
    Lanarkshire
    British127760350001
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Director
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish69200640003
    WALLACE, Neale Howard
    17 Greenside
    Denby Dale
    HD8 8QY Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    17 Greenside
    Denby Dale
    HD8 8QY Huddersfield
    West Yorkshire
    British43081660003

    ¿Tiene ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 19 may 2008
    Entregado el 22 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The goods X687YUG 001281 volvo X688YUG 001275 volvo X689YUG 001260 volvo arriva yorkshire west limited for further items charged please see form 395 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 23 nov 2006
    Entregado el 02 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in the goods being chassis: 13336 vdl.reg no:YJ06 wwv.chassis type:DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13335 vdl. Reg no: YJ06 wwl. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13337 vdl. Reg no: YJ06 wwx. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. (For details of further goods charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 15 jun 1995
    Entregado el 20 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston("the Agent") as Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 20 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 01 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 13 abr 1995
    Entregado el 20 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,335,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge over the goods listed in the schedule to the form 395 including several leyland lynx, dennis lance and mercedes benz. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 20 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 23 mar 1990
    Entregado el 29 mar 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed chage over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above). Uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 mar 1990Registro de una carga
    • 30 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 feb 2017Inicio de la liquidación
    25 dic 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Profesional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0