THE UK CHANNEL LIMITED

THE UK CHANNEL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE UK CHANNEL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02301363
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE UK CHANNEL LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra THE UK CHANNEL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The London Television Centre
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED20 jul 198920 jul 1989
    MANI LIMITED30 sept 198830 sept 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE UK CHANNEL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 nov 2009

    Estado de capital el 24 nov 2009

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cambio de datos del director Eleanor Kate Irving el 16 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Helen Jane Tautz el 16 oct 2009

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF el 12 oct 2009

    1 páginasAD01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    4 páginas363a

    Memorándum y Estatutos

    8 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)a 22/09/2008
    RES13

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    2 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    IRVING, Eleanor Kate
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Director
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish79177030002
    TAUTZ, Helen Jane
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Director
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish37564540001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Secretario
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    HOWLE, Michael Anthony
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    Secretario
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    British32460850001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Secretario
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    ANCLIFF, Christopher John
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    Director
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    British52876050001
    BIRDSEYE, Sarah Elizabeth
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    Director
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    British69659880002
    BUGGY, Alan Richard
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    Director
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    American4860890001
    CONSTANT, Richard Michael
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    Director
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    United KingdomBritish43836310003
    CRESSWELL, John
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    Director
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish39795820003
    DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    Director
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    EnglandBritish52448400001
    FORREST, Ian Mcclure
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    Director
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    British2327400003
    GOROG, William Christopher
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    Director
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    American96074620002
    HAIMOVITZ, Jules
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    Director
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    American43075680001
    HUTCHINGS, David George
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    Director
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    British10085500002
    JACQUES, John Douglas
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    Director
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    British3170310001
    JOHNSON, David
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    Director
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish76706450001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Director
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    MARRINAN, James
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    Director
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    American17905570001
    MEDLICOTT, William Jonathan
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    Director
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    EnglandEnglish44636500002
    POHL, Henry Theodore
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    Director
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    British32450180001
    SANITSKY, Robert
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Director
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Usa53433450001
    SMITH, Kathryn
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    Director
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    British77161950001
    TILL, Stewart Myles
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    Director
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    British24204890001
    WILLIAMS, Lucinda Mary
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Director
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British55121890001

    ¿Tiene THE UK CHANNEL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 06 feb 1991
    Entregado el 14 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined
    Breve descripción
    (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for and on Behalf of Trelfand the Banks
    Transacciones
    • 14 feb 1991Registro de una carga
    • 27 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement
    Creado el 05 feb 1991
    Entregado el 14 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descripción
    All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transacciones
    • 14 feb 1991Registro de una carga
    • 27 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trademark security agreement
    Creado el 05 feb 1991
    Entregado el 14 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descripción
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transacciones
    • 14 feb 1991Registro de una carga
    • 27 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited)
    Creado el 05 feb 1991
    Entregado el 14 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descripción
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transacciones
    • 14 feb 1991Registro de una carga
    • 27 ene 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0