TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED

TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02305096
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    • Operación de instalaciones de almacenamiento y depósito para actividades de transporte terrestre (52103) / Transporte y almacenamiento
    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LOWFIELD DISTRIBUTION LIMITED25 oct 198825 oct 1988
    FACTORMADE LIMITED13 oct 198813 oct 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Memorándum y Estatutos

    3 páginasMEM/ARTS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2013

    Estado de capital el 02 jul 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Estado de capital el 23 may 2013

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium and capital reserve cancelled 09/05/2013
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ian Cameron como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Roger Mann como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Exel Secretarial Services Limited como director

    2 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Exel Nominee No 2 Limited como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Roger Michael Ewart Mann como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Waters como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    England
    Secretario corporativo
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro817717
    32524900007
    CAMERON, Ian, Mr.
    66 High Street
    Stagsden
    MK43 8SQ Bedford
    Gamekeepers Cottage
    England
    Director
    66 High Street
    Stagsden
    MK43 8SQ Bedford
    Gamekeepers Cottage
    England
    EnglandBritish164576100001
    TAYLOR, Paul
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    Director
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish105652320001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro817717
    32524900007
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secretario
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    British193353200001
    SMITH, Nicholas Leigh
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British45625440002
    SQUIRE, Angela Elizabeth
    5 Coppice Close
    NN11 4BD Daventry
    Northamptonshire
    Secretario
    5 Coppice Close
    NN11 4BD Daventry
    Northamptonshire
    British30731030001
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Secretario
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    British15165070001
    ADAMSON, John Stephen
    Westfield
    Westfield Lane Swanland
    HU14 3PG Hull
    North Humberside
    Director
    Westfield
    Westfield Lane Swanland
    HU14 3PG Hull
    North Humberside
    British34467580001
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69617780001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Director
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    ELLIS, Michael John
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    Director
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    EnglandBritish133791220001
    FRIEND, Jonathan Edward
    42 Bush Grove
    HA7 2DZ Stanmore
    Middlesex
    Director
    42 Bush Grove
    HA7 2DZ Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish12300070001
    GOULD, Kenneth
    Wallow End Long Barrow
    Chipping Warden
    OX17 1JR Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Wallow End Long Barrow
    Chipping Warden
    OX17 1JR Banbury
    Oxfordshire
    British50535050001
    GRAHAM, Martin
    Sherrington Bridge Lodge
    Sherrington
    MK16 9JA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Director
    Sherrington Bridge Lodge
    Sherrington
    MK16 9JA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British112304040001
    HARVEY, John Anthony
    32 Frithwood Avenue
    HA6 3LU Northwood
    Middlesex
    Director
    32 Frithwood Avenue
    HA6 3LU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish35542690001
    HOWES, David William
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    Director
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    British53711750001
    MANN, Roger Michael Ewart
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Director
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish15476780001
    MELLOR, Kevin Donald
    115 Pine Hill
    KT18 7BJ Epsom
    Surrey
    Director
    115 Pine Hill
    KT18 7BJ Epsom
    Surrey
    British13004030001
    MUSGRAVE, David
    2 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    2 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish107853930001
    RYAN, Denzil
    4 The Dells
    Leverstock Green
    HP3 8HJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    4 The Dells
    Leverstock Green
    HP3 8HJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British17332770001
    SMITH, James Fergus Neil
    Stone End
    Chapel Close Towcester Road
    NN12 8JA Litchborough
    Northamptonshire
    Director
    Stone End
    Chapel Close Towcester Road
    NN12 8JA Litchborough
    Northamptonshire
    British17332750002
    SMITH, Jamie Robert Mark
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    Director
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish74084830002
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Director
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish15165070001
    WATERS, Christopher Stephen
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish54969250001
    WILLIAMS, Brian Clifford
    12 Hamlet Green
    Dallington
    NN5 7AR Northampton
    Northamptonshire
    Director
    12 Hamlet Green
    Dallington
    NN5 7AR Northampton
    Northamptonshire
    British12341170003
    EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1183615
    73807850002

    ¿Tiene TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 18 sept 1989
    Entregado el 25 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 17/12/88
    Breve descripción
    1.54 acres being the subjects described in disposition by townson developments (lancashire) LTD.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security (reg in scotland)
    Creado el 24 jul 1989
    Entregado el 04 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 04/7/89
    Breve descripción
    3030 sq yds at harthill 7.5 acres at harthill.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 ago 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for reg. In scotland on 18/1/89
    Creado el 18 ene 1989
    Entregado el 26 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 19/12/88
    Breve descripción
    3030 sq. Yards at harthill described in disposition by the secretary of state for scotland in favour of imperial tobacco group LTD recorded grs lanark 21/4/70 (see form 395 for details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ene 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on the 18/1/89
    Creado el 18 ene 1989
    Entregado el 26 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 19/12/88
    Breve descripción
    1.158 acres at grantown-on-spey described in feu disposition by the rt.hon. Nina caroline ogilvie grant, countess of seafield in favour of george marshall scott and another recorded grs moray 28.7.71 (for full details see form 395 ref. M3520).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ene 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Gurantee & debenture
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 05 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or marginbold limited to the chargee on any account whatsover.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1989Registro de una carga
    • 08 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 09 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises at plot 20, amington industrial estate tamworth staffordshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 09 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    4 and 6 church walk, daventry northamptonshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1989Registro de una carga
    • 25 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 30 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings lying to the south-west of lowfield lane, leagreen, merseyside title no's la 184391 and ms 126.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 30 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the south-west of barnsley road, dodworth south, yorkshire title no syk 117262.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 30 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the north-east of nash road, newport, gwent title no wa 20309.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 dic 1988
    Entregado el 30 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and factory on north-east side of hermitage lane, barming kent title no K287141.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1988Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0