TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02305096 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
- Operación de instalaciones de almacenamiento y depósito para actividades de transporte terrestre (52103) / Transporte y almacenamiento
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
| Dirección de la sede social | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LOWFIELD DISTRIBUTION LIMITED | 25 oct 1988 | 25 oct 1988 |
| FACTORMADE LIMITED | 13 oct 1988 | 13 oct 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 3 páginas | MEM/ARTS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 23 may 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Cameron como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Mann como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Exel Secretarial Services Limited como director | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Exel Nominee No 2 Limited como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Roger Michael Ewart Mann como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Waters como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England |
| 32524900007 | ||||||||||
| CAMERON, Ian, Mr. | Director | 66 High Street Stagsden MK43 8SQ Bedford Gamekeepers Cottage England | England | British | 164576100001 | |||||||||
| TAYLOR, Paul | Director | 2a High Street Ringstead NN14 4DA Kettering Northamptonshire | England | British | 105652320001 | |||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director corporativo | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Secretario | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| MILLS, John Michael | Secretario | 103 Moffats Lane AL9 7RP Brookmans Park Hertfordshire | British | 193353200001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Secretario | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| SQUIRE, Angela Elizabeth | Secretario | 5 Coppice Close NN11 4BD Daventry Northamptonshire | British | 30731030001 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Secretario | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| ADAMSON, John Stephen | Director | Westfield Westfield Lane Swanland HU14 3PG Hull North Humberside | British | 34467580001 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Director | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 64948610002 | |||||||||
| AUSTIN, Keith James | Director | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 69617780001 | |||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Director | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| ELLIS, Michael John | Director | Little Trodgers Honor End Lane, Prestwood HP16 9HG Buckinghamshire | England | British | 133791220001 | |||||||||
| FRIEND, Jonathan Edward | Director | 42 Bush Grove HA7 2DZ Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 12300070001 | |||||||||
| GOULD, Kenneth | Director | Wallow End Long Barrow Chipping Warden OX17 1JR Banbury Oxfordshire | British | 50535050001 | ||||||||||
| GRAHAM, Martin | Director | Sherrington Bridge Lodge Sherrington MK16 9JA Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 112304040001 | ||||||||||
| HARVEY, John Anthony | Director | 32 Frithwood Avenue HA6 3LU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 35542690001 | |||||||||
| HOWES, David William | Director | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||||||
| MANN, Roger Michael Ewart | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 15476780001 | |||||||||
| MELLOR, Kevin Donald | Director | 115 Pine Hill KT18 7BJ Epsom Surrey | British | 13004030001 | ||||||||||
| MUSGRAVE, David | Director | 2 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 107853930001 | |||||||||
| RYAN, Denzil | Director | 4 The Dells Leverstock Green HP3 8HJ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 17332770001 | ||||||||||
| SMITH, James Fergus Neil | Director | Stone End Chapel Close Towcester Road NN12 8JA Litchborough Northamptonshire | British | 17332750002 | ||||||||||
| SMITH, Jamie Robert Mark | Director | Tanglewood 33 Woodend Drive SL5 9BD Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 74084830002 | |||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Director | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | England | British | 15165070001 | |||||||||
| WATERS, Christopher Stephen | Director | 5 Five Acres WD4 9JU Kings Langley Hertfordshire | England | British | 54969250001 | |||||||||
| WILLIAMS, Brian Clifford | Director | 12 Hamlet Green Dallington NN5 7AR Northampton Northamptonshire | British | 12341170003 | ||||||||||
| EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED | Director corporativo | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 73807850002 |
¿Tiene TIBBETT & BRITTEN CONSUMER LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 18 sept 1989 Entregado el 25 sept 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 17/12/88 | |
Breve descripción 1.54 acres being the subjects described in disposition by townson developments (lancashire) LTD. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security (reg in scotland) | Creado el 24 jul 1989 Entregado el 04 ago 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 04/7/89 | |
Breve descripción 3030 sq yds at harthill 7.5 acres at harthill. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security presented for reg. In scotland on 18/1/89 | Creado el 18 ene 1989 Entregado el 26 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 19/12/88 | |
Breve descripción 3030 sq. Yards at harthill described in disposition by the secretary of state for scotland in favour of imperial tobacco group LTD recorded grs lanark 21/4/70 (see form 395 for details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on the 18/1/89 | Creado el 18 ene 1989 Entregado el 26 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 19/12/88 | |
Breve descripción 1.158 acres at grantown-on-spey described in feu disposition by the rt.hon. Nina caroline ogilvie grant, countess of seafield in favour of george marshall scott and another recorded grs moray 28.7.71 (for full details see form 395 ref. M3520). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Gurantee & debenture | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 05 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or marginbold limited to the chargee on any account whatsover. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 09 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and premises at plot 20, amington industrial estate tamworth staffordshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 09 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 4 and 6 church walk, daventry northamptonshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 30 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings lying to the south-west of lowfield lane, leagreen, merseyside title no's la 184391 and ms 126. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 30 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land lying to the south-west of barnsley road, dodworth south, yorkshire title no syk 117262. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 30 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land lying to the north-east of nash road, newport, gwent title no wa 20309. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1988 Entregado el 30 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and factory on north-east side of hermitage lane, barming kent title no K287141. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0