COBRA TUBBS BATTEN LIMITED

COBRA TUBBS BATTEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOBRA TUBBS BATTEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02309819
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    • (6603) /

    ¿Dónde se encuentra COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TUBBS INSURANCE SERVICES LIMITED20 mar 199720 mar 1997
    BIGMORE TUBBS LIMITED03 oct 198903 oct 1989
    FLUXCOOL LIMITED27 oct 198827 oct 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 feb 2014

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 feb 2013

    5 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Jaeger House 5 Clanricarde Gardens Tunbridge Wells Kent TN1 1PE el 29 nov 2012

    2 páginasAD01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Domicilio social registrado cambiado de 110 Fenchurch Street London EC3M 5JT el 24 feb 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Philip Douglas Truman como director el 30 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shawn Biles como director el 30 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark John Zandler como director el 30 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2011

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 06 jun 2011

    17 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jul 2011

    Estado de capital el 06 jul 2011

    • Capital: GBP 352,632
    SH01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    2 páginasAD04

    Cese del nombramiento de Slc Registrars Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Mackinnon como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 06 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    27 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    ¿Quiénes son los directivos de COBRA TUBBS BATTEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURROWS, Stephen Mark
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    Director
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector13539590001
    STANLEY, David George Edward
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    Director
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    EnglandBritishAccountant79784840001
    DAVIES, John
    Chilton Stonehill Crescent
    Ottershaw
    KT16 0EP Chertsey
    Surrey
    Secretario
    Chilton Stonehill Crescent
    Ottershaw
    KT16 0EP Chertsey
    Surrey
    British12653210001
    JERRETT, David Alfred
    Owl Cottage
    51 Bevern Bridge
    BN8 4QB South Chailey
    Lewes Sussex
    Secretario
    Owl Cottage
    51 Bevern Bridge
    BN8 4QB South Chailey
    Lewes Sussex
    British39874720001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Secretario corporativo
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    Secretario corporativo
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    111052920001
    BIGMORE, William Mcgregor
    Flat 1 17 Ashdown House
    Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Flat 1 17 Ashdown House
    Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector44192080001
    BILES, Shawn
    The Lodge
    40 Maple Leaf Drive
    GU35 0JU Bordon
    Hampshire
    Director
    The Lodge
    40 Maple Leaf Drive
    GU35 0JU Bordon
    Hampshire
    BritishInsurance Broker121637260001
    CARTER, Neil Kenneth
    20 Church Close
    Fetcham
    KT22 9BQ Leatherhead
    Surrey
    Director
    20 Church Close
    Fetcham
    KT22 9BQ Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director6694010001
    DAVIES, John
    Chilton Stonehill Crescent
    Ottershaw
    KT16 0EP Chertsey
    Surrey
    Director
    Chilton Stonehill Crescent
    Ottershaw
    KT16 0EP Chertsey
    Surrey
    BritishCompany Director12653210001
    MACKINNON, David
    29 Greenhill Close
    Copped Hall
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    Director
    29 Greenhill Close
    Copped Hall
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishInsurance Broker121621480001
    MARSHALL, Roger David
    2 Ottermead Cottages
    Ottermead Lane
    KT16 0HJ Ottershaw
    Surrey
    Director
    2 Ottermead Cottages
    Ottermead Lane
    KT16 0HJ Ottershaw
    Surrey
    BritishCompany Director73017460001
    POULTON, Hannah
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    Director
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    BritishChartered Accountant99706350001
    TRUMAN, Philip Douglas
    Smalls Hill Road
    Leigh
    RH2 8QA Reigate
    Little Mynthhurst
    Surrey
    Director
    Smalls Hill Road
    Leigh
    RH2 8QA Reigate
    Little Mynthhurst
    Surrey
    EnglandBritishDirector23668310008
    ZANDLER, Mark John
    The Flint House
    Dean Lane
    RH1 3AH Merstham
    Surrey
    Director
    The Flint House
    Dean Lane
    RH1 3AH Merstham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector44086200003

    ¿Tiene COBRA TUBBS BATTEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 feb 2009
    Entregado el 26 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 26 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession to a guarantee and debenture
    Creado el 19 ene 2009
    Entregado el 09 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 9-11 high street, alton, hampshire t/no SH12795, f/h property k/a 139 and 141 manchester road, broadheath, altrincham, cheshire t/no GM768625 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transacciones
    • 09 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 19 ene 2009
    Entregado el 31 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other charging company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wainford Holdings Limited (Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene COBRA TUBBS BATTEN LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 feb 2012Inicio de la liquidación
    12 abr 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Vincent John Green
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Mark Newman
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent
    Profesional
    Ccw Recovery Solutions Llp Jaeger House
    5 Clanricarde Gardens
    TN1 1PE Tunbridge Wells
    Kent

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0