TERMINUS 12 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTERMINUS 12 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02320873
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TERMINUS 12 LIMITED?

    • (2222) /

    ¿Dónde se encuentra TERMINUS 12 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TERMINUS 12 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    POLESTAR CARLISLE LIMITED06 nov 199806 nov 1998
    BPC CARLISLE LTD26 nov 199626 nov 1996
    BPC MAGAZINES (CARLISLE) LTD18 ene 199418 ene 1994
    BPCC MAGAZINES (CARLISLE) LTD07 may 199107 may 1991
    BPCC BUSINESS MAGAZINES (CARLISLE) LTD04 may 198904 may 1989
    NICKELOID (SALES) LIMITED23 ene 198923 ene 1989
    GLENMULTI LIMITED23 nov 198823 nov 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TERMINUS 12 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TERMINUS 12 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 may 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2010

    Estado de capital el 20 oct 2010

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Alan Goodwin el 31 jul 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Alan Goodwin el 31 jul 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2008

    8 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2007

    8 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2006

    9 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2005

    9 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TERMINUS 12 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Secretario
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Director
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Director
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Director
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Director
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Director
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    LEACH, Alan Joseph
    59 Cairn Wood
    Heads Nook
    CA4 9AH Carlisle
    Cumbria
    Director
    59 Cairn Wood
    Heads Nook
    CA4 9AH Carlisle
    Cumbria
    BritishGeneral Manager30356950001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Director
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Director
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    WATSON, Peter
    Park House Langrigg
    Aspatria
    CA5 3LL Carlisle
    Cumbria
    Director
    Park House Langrigg
    Aspatria
    CA5 3LL Carlisle
    Cumbria
    BritishGeneral Manager66119150002
    WESTMORLAND, Michael John
    2 Bellflower Grove
    Stewartfield East Kilbride
    G74 4TB Glasgow
    Director
    2 Bellflower Grove
    Stewartfield East Kilbride
    G74 4TB Glasgow
    BritishFinance Director44289570002

    ¿Tiene TERMINUS 12 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Creado el 28 oct 2004
    Entregado el 10 nov 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transacciones
    • 10 nov 2004Registro de un cargo (395)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Creado el 28 oct 2004
    Entregado el 10 nov 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transacciones
    • 10 nov 2004Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 19 jun 1998
    Entregado el 10 jul 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Breve descripción
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited
    Transacciones
    • 10 jul 1998Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 28 dic 1995
    Entregado el 08 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 08 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 28 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Breve descripción
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 13 ene 1989
    Entregado el 27 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from bucksmere limited to the chargee under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 as defined in this deed on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bankas Agent & Trustee for the Lenders
    Transacciones
    • 27 ene 1989Registro de una carga
    • 24 sept 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 13 ene 1989
    Entregado el 27 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from bucksmere limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of "the facilities agreement" d/d 21/12/88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank.
    Transacciones
    • 27 ene 1988Registro de una carga
    • 22 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0