B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED

B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaB.I.B. UNDERWRITERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02321506
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
    • Reaseguro no de vida (65202) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    B.I.B. (CLEVELAND) LIMITED25 nov 198825 nov 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021

    16 páginasAA

    legacy

    215 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Estado de capital el 29 mar 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Dean Clarke como secretario el 27 ene 2022

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ardonagh Corporate Secretary Limited como secretario el 27 ene 2022

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Scott William Hough como director el 27 ene 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonathan Guy Sutton como director el 27 ene 2022

    2 páginasAP01

    Memorándum y Estatutos

    20 páginasMA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Memorándum y Estatutos

    20 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    38 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Scott William Hough el 12 oct 2020

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03702575
    288842300001
    COLES, Derek John
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish114763370001
    SUTTON, Jonathan Guy, Mr
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish292196320001
    ATKINSON, Peter
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    Secretario
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    British8775510002
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    155742990001
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secretario
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253940570001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087740001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    208512110001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    222331280001
    JOWETT, Marion
    5 Mill Croft
    DL10 4TR Richmond
    North Yorkshire
    Secretario
    5 Mill Croft
    DL10 4TR Richmond
    North Yorkshire
    British16445080001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    183283520001
    ATKINSON, Peter
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    Director
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish8775510002
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish125097020001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish171398800001
    CARTER, Christopher David
    7 Meadow Court
    Scruton
    DL7 0QU Northallerton
    North Yorkshire
    Director
    7 Meadow Court
    Scruton
    DL7 0QU Northallerton
    North Yorkshire
    British8775520001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish149939610001
    DILLEY, Paul John
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish253688230001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriot167795710001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish58444370003
    HOUGH, Scott William
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish85495940006
    KENT, Christopher John
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish253698330001
    LITTLETON, Martin Paul
    The Gill
    Harmby
    DL8 5PE Leyburn
    North Yorkshire
    Director
    The Gill
    Harmby
    DL8 5PE Leyburn
    North Yorkshire
    United KingdomBritish8775530001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish147194830001
    RECORD, Stephen Paul
    45 Baydale Road
    DL3 8JT Darlington
    County Durham
    Director
    45 Baydale Road
    DL3 8JT Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish94239820001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5216169
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of accession
    Creado el 22 feb 2011
    Entregado el 03 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties)
    Transacciones
    • 03 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 06 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession
    Creado el 22 feb 2011
    Entregado el 03 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties)
    Transacciones
    • 03 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 06 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 04 oct 1996
    Entregado el 10 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or B.I.B. (darlington) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    150,152 and 154 northgate darlington durham t/n DU51910.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 21 sept 1990
    Entregado el 05 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 1990Registro de una carga
    • 24 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 19 ene 1990
    Entregado el 30 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ene 1990Registro de una carga
    • 04 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 20 jun 1989
    Entregado el 27 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 jun 1989Registro de una carga
    • 04 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0