B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02321506 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
- Reaseguro no de vida (65202) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| B.I.B. (CLEVELAND) LIMITED | 25 nov 1988 | 25 nov 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 215 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 29 mar 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 p áginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Clarke como secretario el 27 ene 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ardonagh Corporate Secretary Limited como secretario el 27 ene 2022 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott William Hough como director el 27 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Guy Sutton como director el 27 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 38 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Scott William Hough el 12 oct 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom |
| 288842300001 | ||||||||||
| COLES, Derek John | Director | Lakeside Boulevard DN4 5PL Doncaster Quay Point South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 114763370001 | |||||||||
| SUTTON, Jonathan Guy, Mr | Director | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | England | British | 292196320001 | |||||||||
| ATKINSON, Peter | Secretario | 22 Foxglove Close Romanby DL7 8FB Northallerton North Yorkshire | British | 8775510002 | ||||||||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Secretario | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | 155742990001 | |||||||||||
| CLARKE, Dean | Secretario | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | 253940570001 | |||||||||||
| GOURIET, Geoffrey Costerton | Secretario | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 249087740001 | |||||||||||
| GOURIET, Geoffrey Costerton | Secretario | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 208512110001 | |||||||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 222331280001 | |||||||||||
| JOWETT, Marion | Secretario | 5 Mill Croft DL10 4TR Richmond North Yorkshire | British | 16445080001 | ||||||||||
| OWENS, Jennifer | Secretario | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | 183283520001 | |||||||||||
| ATKINSON, Peter | Director | 22 Foxglove Close Romanby DL7 8FB Northallerton North Yorkshire | United Kingdom | British | 8775510002 | |||||||||
| BARR, Graham Maxwell | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 125097020001 | |||||||||
| BRUCE, David James | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 171398800001 | |||||||||
| CARTER, Christopher David | Director | 7 Meadow Court Scruton DL7 0QU Northallerton North Yorkshire | British | 8775520001 | ||||||||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 149939610001 | |||||||||
| DILLEY, Paul John | Director | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | England | British | 253688230001 | |||||||||
| EGAN, Scott | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 170703910001 | |||||||||
| EROTOCRITOU, Antonios | Director | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | United Kingdom | Cypriot | 167795710001 | |||||||||
| HODGES, Mark Steven | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||||||
| HOUGH, Scott William | Director | Lakeside Boulevard DN4 5PL Doncaster Quay Point South Yorkshire United Kingdom | England | British | 85495940006 | |||||||||
| KENT, Christopher John | Director | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 253698330001 | |||||||||
| LITTLETON, Martin Paul | Director | The Gill Harmby DL8 5PE Leyburn North Yorkshire | United Kingdom | British | 8775530001 | |||||||||
| MUGGE, Mark Stephen | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | 162920630005 | |||||||||
| PARK, Bryan | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 113694470002 | |||||||||
| REA, Michael Peter | Director | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 147194830001 | |||||||||
| RECORD, Stephen Paul | Director | 45 Baydale Road DL3 8JT Darlington County Durham | United Kingdom | British | 94239820001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.I.B.U Acquisitions Limited | 06 abr 2016 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creado el 22 feb 2011 Entregado el 03 mar 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession | Creado el 22 feb 2011 Entregado el 03 mar 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 04 oct 1996 Entregado el 10 oct 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or B.I.B. (darlington) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 150,152 and 154 northgate darlington durham t/n DU51910. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 21 sept 1990 Entregado el 05 oct 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 19 ene 1990 Entregado el 30 ene 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 20 jun 1989 Entregado el 27 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0