GAZELEY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GAZELEY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02322154 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GAZELEY LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GAZELEY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 50 New Bond Street W1S 1BJ London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GAZELEY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GAZELEY HOLDINGS LIMITED | 28 nov 1988 | 28 nov 1988 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GAZELEY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GAZELEY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 mar 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 abr 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 mar 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GAZELEY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Michael Charles Radcliffe como director el 24 mar 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Benjamin James Marks como director el 23 mar 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de una carga con orden judicial de Charles para prorrogar. Código de carga 023221540028, creada el 09 oct 2024 | 191 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540027, creada el 23 ene 2025 | 112 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540020, creada el 19 nov 2024 | 54 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540021, creada el 19 nov 2024 | 40 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540022, creada el 19 nov 2024 | 82 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540023, creada el 19 nov 2024 | 21 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540024, creada el 19 nov 2024 | 62 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540025, creada el 19 nov 2024 | 36 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 023221540026, creada el 19 nov 2024 | 45 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 29 páginas | AA | ||
Cancelación total de la carga 023221540012 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 023221540013 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 023221540014 | 1 páginas | MR04 | ||
Modification des détails de Gazeley Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 28 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Benjamin James Marks como director el 17 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como secretario el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como director el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de GAZELEY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADCLIFFE, Michael Charles | Director | New Bond Street W1S 1BJ London 50 | England | British | 346878050001 | |||||
| TOPLEY, Bruce Alistair | Director | New Bond Street W1S 1BJ London 50 | England | British | 261055080001 | |||||
| BEHRENS, James Henry John | Secretario | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | Other | 140186420001 | ||||||
| BERKOFF, Stuart Charles | Secretario | Green Lane HA8 7QA Edgware 68 Middlesex England | 161302860001 | |||||||
| BOULTON, Jennie | Secretario | 45 Isaacson Drive Wavendon Gate MK7 7RQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 61656850002 | ||||||
| CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline | Secretario | 4 Benbow Close LE10 1RQ Hinckley Leicestershire | British | 68697650001 | ||||||
| COOPER, Nicholas Mark | Secretario | 26 Belle Baulk NN12 6YE Towcester Northants | British | 83131590001 | ||||||
| COX, Philip Robert | Secretario | 7 Greenway HG2 9LR Harrogate North Yorkshire | British | 58419290002 | ||||||
| DOOHAN, Eleanor | Secretario | 8 Station Lane LS14 3JF Thorner West Yorkshire | British | 101502950001 | ||||||
| FERNANDEZ, Michelle | Secretario | 1 Milesmere Two Mile Ash MK8 8DP Milton Keynes Buckinghamshire | British | 98129630001 | ||||||
| JAGGER, Denise Nichola | Secretario | Water Fulford Hall Naburn Lane Fulford YO19 4RB York North Yorkshire | British | 1304090001 | ||||||
| KELLY, Shane Roger | Secretario | New Bond Street W1S 1BJ London 50 | 186641950001 | |||||||
| YOUNG, Craig Robert | Secretario | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | 157184860001 | |||||||
| ALABBASI, Asim Abdulwahed Abduljaleel | Director | 335/23 Al Diffa Road Nr Stadium 10th Fl Flat 1004 Dubai H H The Rulers Bldg Dubai | U A E | 130978620001 | ||||||
| BERKOFF, Stuart Charles | Director | Green Lane HA8 7QA Edgware 68 Middlesex England | United Kingdom | British | 125709190002 | |||||
| BIN HAREB, Salma Ali Saif Saeed | Director | Jabal Ali Properties Villa 185 500 Jabal Ali Village Post Box 17000 Dubai Dubai | U A E | 131903420001 | ||||||
| BOND, Andrew James | Director | The Hunting Box The Nook Bitteswell LE17 4RY Lutterworth Leiceshire | United Kingdom | British | 141599340001 | |||||
| BOULTON, Susan Jennie Mildred | Director | 10 Passalewe Lane Wavendon Gate MK7 7RF Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 61656850009 | |||||
| CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline | Director | 4 Benbow Close LE10 1RQ Hinckley Leicestershire | British | 68697650001 | ||||||
| COOK, Nicholas Robert | Director | 99 Bishopsgate EC2M 3XD London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 241426770001 | |||||
| COX, Philip Robert | Director | Stone Garth Crowhill Lane HG3 2LG High Birstwith North Yorkshire | British | 58419290005 | ||||||
| DUGGAN, John | Director | The Stables Home Farm MK10 9AJ Milton Keynes Village Buckinghamshire | United Kingdom | British | 18472080002 | |||||
| FENTON-JONES, Jonathan Charles | Director | Filmer Grove GU7 3AB Godalming Lammas Lea Surrey United Kingdom | England | British | 20926540002 | |||||
| GALE, Cyril Kenneth | Director | 69 Church Drive East Keswick LS17 9EP Leeds West Yorkshire | British | 31435280001 | ||||||
| GAREL, Jean-Fleury Yves Roger | Director | Via Moscova 20121 Milano 47 Italy | Italy | French | 169025950001 | |||||
| GODFREY, Nigel William John | Director | The Weather House MK18 5LX Shalstone Buckinghamshire | United Kingdom | United Kingdom | 73234830001 | |||||
| GOMERSALL, Peter Anthony | Director | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | England | British | 12359850001 | |||||
| GRIFFITHS, Andrew Donald | Director | Cruck House 38 Main Street LE6 0AD Newton Linford Leicestershire | United Kingdom | British | 56528380003 | |||||
| HASAN, Mahmood Iqbal | Director | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | England | British | 164450370001 | |||||
| JONES, Richard William | Director | 18 Fairford Avenue LU2 7ER Luton | United Kingdom | British | 74514660002 | |||||
| KARMANN, Thomas Rudolf | Director | 10 Rue Charles Sadoul Metz 57000 France | German | 123181020001 | ||||||
| KELLY, Shane Roger | Director | New Bond Street W1S 1BJ London 50 | United Kingdom | British | 179642130002 | |||||
| KEW, Philip Anthony | Director | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||
| MARKS, Benjamin James | Director | New Bond Street W1S 1BJ London 50 | United Kingdom | British | 81100240007 | |||||
| MCGILLYCUDDY, Patrick John | Director | 99 Bishopsgate EC2M 3XD London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 146257370001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GAZELEY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Income Investments Uk Limited | 20 dic 2017 | St. James's Square Suite 1, 3rd Floor SW1Y 4LB London 11-12 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Pearl Income Holdings Uk Limited | 20 dic 2017 | St. James's Square Suite 1, 3rd Floor SW1Y 4LB London 11-12 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Gazeley Holdings Uk Limited | 20 dic 2017 | New Bond Street W1S 1BJ London 50 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc | 06 abr 2016 | 181 Bay Street Suite 300 Toronto, M5j 2t3 Brookfield Place Canada | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0