GAZELEY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGAZELEY LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02322154
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GAZELEY LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GAZELEY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    50 New Bond Street
    W1S 1BJ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GAZELEY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GAZELEY HOLDINGS LIMITED28 nov 198828 nov 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GAZELEY LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GAZELEY LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta19 mar 2027
    Próxima declaración de confirmación vence02 abr 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta19 mar 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GAZELEY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Michael Charles Radcliffe como director el 24 mar 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Benjamin James Marks como director el 23 mar 2026

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de una carga con orden judicial de Charles para prorrogar. Código de carga 023221540028, creada el 09 oct 2024

    191 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540027, creada el 23 ene 2025

    112 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540020, creada el 19 nov 2024

    54 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540021, creada el 19 nov 2024

    40 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540022, creada el 19 nov 2024

    82 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540023, creada el 19 nov 2024

    21 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540024, creada el 19 nov 2024

    62 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540025, creada el 19 nov 2024

    36 páginasMR01

    Registro de la carga 023221540026, creada el 19 nov 2024

    45 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    29 páginasAA

    Cancelación total de la carga 023221540012

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 023221540013

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 023221540014

    1 páginasMR04

    Modification des détails de Gazeley Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 dic 2017

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    28 páginasAA

    Nombramiento de Mr Benjamin James Marks como director el 17 jul 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como secretario el 27 jun 2023

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como director el 27 jun 2023

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GAZELEY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RADCLIFFE, Michael Charles
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    Director
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    EnglandBritish346878050001
    TOPLEY, Bruce Alistair
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    Director
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    EnglandBritish261055080001
    BEHRENS, James Henry John
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Secretario
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Other140186420001
    BERKOFF, Stuart Charles
    Green Lane
    HA8 7QA Edgware
    68
    Middlesex
    England
    Secretario
    Green Lane
    HA8 7QA Edgware
    68
    Middlesex
    England
    161302860001
    BOULTON, Jennie
    45 Isaacson Drive
    Wavendon Gate
    MK7 7RQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    45 Isaacson Drive
    Wavendon Gate
    MK7 7RQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61656850002
    CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline
    4 Benbow Close
    LE10 1RQ Hinckley
    Leicestershire
    Secretario
    4 Benbow Close
    LE10 1RQ Hinckley
    Leicestershire
    British68697650001
    COOPER, Nicholas Mark
    26 Belle Baulk
    NN12 6YE Towcester
    Northants
    Secretario
    26 Belle Baulk
    NN12 6YE Towcester
    Northants
    British83131590001
    COX, Philip Robert
    7 Greenway
    HG2 9LR Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    7 Greenway
    HG2 9LR Harrogate
    North Yorkshire
    British58419290002
    DOOHAN, Eleanor
    8 Station Lane
    LS14 3JF Thorner
    West Yorkshire
    Secretario
    8 Station Lane
    LS14 3JF Thorner
    West Yorkshire
    British101502950001
    FERNANDEZ, Michelle
    1 Milesmere
    Two Mile Ash
    MK8 8DP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    1 Milesmere
    Two Mile Ash
    MK8 8DP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British98129630001
    JAGGER, Denise Nichola
    Water Fulford Hall
    Naburn Lane Fulford
    YO19 4RB York
    North Yorkshire
    Secretario
    Water Fulford Hall
    Naburn Lane Fulford
    YO19 4RB York
    North Yorkshire
    British1304090001
    KELLY, Shane Roger
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    Secretario
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    186641950001
    YOUNG, Craig Robert
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Secretario
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    157184860001
    ALABBASI, Asim Abdulwahed Abduljaleel
    335/23 Al Diffa Road
    Nr Stadium 10th Fl Flat 1004
    Dubai
    H H The Rulers Bldg
    Dubai
    Director
    335/23 Al Diffa Road
    Nr Stadium 10th Fl Flat 1004
    Dubai
    H H The Rulers Bldg
    Dubai
    U A E130978620001
    BERKOFF, Stuart Charles
    Green Lane
    HA8 7QA Edgware
    68
    Middlesex
    England
    Director
    Green Lane
    HA8 7QA Edgware
    68
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish125709190002
    BIN HAREB, Salma Ali Saif Saeed
    Jabal Ali Properties Villa 185 500 Jabal
    Ali Village Post Box 17000
    Dubai
    Dubai
    Director
    Jabal Ali Properties Villa 185 500 Jabal
    Ali Village Post Box 17000
    Dubai
    Dubai
    U A E131903420001
    BOND, Andrew James
    The Hunting Box The Nook
    Bitteswell
    LE17 4RY Lutterworth
    Leiceshire
    Director
    The Hunting Box The Nook
    Bitteswell
    LE17 4RY Lutterworth
    Leiceshire
    United KingdomBritish141599340001
    BOULTON, Susan Jennie Mildred
    10 Passalewe Lane
    Wavendon Gate
    MK7 7RF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    10 Passalewe Lane
    Wavendon Gate
    MK7 7RF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish61656850009
    CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline
    4 Benbow Close
    LE10 1RQ Hinckley
    Leicestershire
    Director
    4 Benbow Close
    LE10 1RQ Hinckley
    Leicestershire
    British68697650001
    COOK, Nicholas Robert
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    6th Floor
    United Kingdom
    Director
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish241426770001
    COX, Philip Robert
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    Director
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    British58419290005
    DUGGAN, John
    The Stables
    Home Farm
    MK10 9AJ Milton Keynes Village
    Buckinghamshire
    Director
    The Stables
    Home Farm
    MK10 9AJ Milton Keynes Village
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish18472080002
    FENTON-JONES, Jonathan Charles
    Filmer Grove
    GU7 3AB Godalming
    Lammas Lea
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Filmer Grove
    GU7 3AB Godalming
    Lammas Lea
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish20926540002
    GALE, Cyril Kenneth
    69 Church Drive
    East Keswick
    LS17 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Director
    69 Church Drive
    East Keswick
    LS17 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British31435280001
    GAREL, Jean-Fleury Yves Roger
    Via Moscova
    20121 Milano
    47
    Italy
    Director
    Via Moscova
    20121 Milano
    47
    Italy
    ItalyFrench169025950001
    GODFREY, Nigel William John
    The Weather House
    MK18 5LX Shalstone
    Buckinghamshire
    Director
    The Weather House
    MK18 5LX Shalstone
    Buckinghamshire
    United KingdomUnited Kingdom73234830001
    GOMERSALL, Peter Anthony
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Director
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    EnglandBritish12359850001
    GRIFFITHS, Andrew Donald
    Cruck House
    38 Main Street
    LE6 0AD Newton Linford
    Leicestershire
    Director
    Cruck House
    38 Main Street
    LE6 0AD Newton Linford
    Leicestershire
    United KingdomBritish56528380003
    HASAN, Mahmood Iqbal
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Director
    Palace Street
    Cardinal Place
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    EnglandBritish164450370001
    JONES, Richard William
    18 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Director
    18 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    United KingdomBritish74514660002
    KARMANN, Thomas Rudolf
    10 Rue Charles Sadoul
    Metz
    57000
    France
    Director
    10 Rue Charles Sadoul
    Metz
    57000
    France
    German123181020001
    KELLY, Shane Roger
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    Director
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    United KingdomBritish179642130002
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Director
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    MARKS, Benjamin James
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    Director
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    United KingdomBritish81100240007
    MCGILLYCUDDY, Patrick John
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    6th Floor
    United Kingdom
    Director
    99 Bishopsgate
    EC2M 3XD London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish146257370001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GAZELEY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Pearl Income Investments Uk Limited
    St. James's Square
    Suite 1, 3rd Floor
    SW1Y 4LB London
    11-12
    England
    20 dic 2017
    St. James's Square
    Suite 1, 3rd Floor
    SW1Y 4LB London
    11-12
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro10988182
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Pearl Income Holdings Uk Limited
    St. James's Square
    Suite 1, 3rd Floor
    SW1Y 4LB London
    11-12
    England
    20 dic 2017
    St. James's Square
    Suite 1, 3rd Floor
    SW1Y 4LB London
    11-12
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro11065839
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Gazeley Holdings Uk Limited
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    England
    20 dic 2017
    New Bond Street
    W1S 1BJ London
    50
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro06601780
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Brookfield Asset Management Inc
    181 Bay Street
    Suite 300
    Toronto, M5j 2t3
    Brookfield Place
    Canada
    06 abr 2016
    181 Bay Street
    Suite 300
    Toronto, M5j 2t3
    Brookfield Place
    Canada
    Forma jurídicaPublic Listed Company
    País de registroCanada
    Autoridad legalCanadian Company Law
    Lugar de registroCanadian Companies House
    Número de registro1644037
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0