FLOMERICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFLOMERICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02327348
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FLOMERICS LIMITED?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra FLOMERICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    81 Bridge Road
    Hampton Court
    KT8 9HH Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FLOMERICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CENTRIGHT LIMITED12 dic 198812 dic 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FLOMERICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FLOMERICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Estado de capital el 02 oct 2012

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium transferred 22/09/2012
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    21 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    21 páginasAA

    Renuncia del auditor

    4 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 04 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    28 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    5 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    8 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    25 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de FLOMERICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WETZEL, Shannon
    Munich 80634
    Arnulfstrasse 201
    Germany
    Secretario
    Munich 80634
    Arnulfstrasse 201
    Germany
    British134659610001
    FREED, Dean Mclean
    2766 Sw Hillsboro Avenue
    Portland Oregon
    97201 Usa
    Director
    2766 Sw Hillsboro Avenue
    Portland Oregon
    97201 Usa
    United StatesAmericanCompany Director46133630001
    VERMIJS, Walter Ernest
    Holten
    Hommelteweg 2
    7451km
    Netherlands
    Director
    Holten
    Hommelteweg 2
    7451km
    Netherlands
    NetherlandsDutchEuropean Controller138281800001
    ADRIAN, Anthony Brian
    1083 Highland View Loop
    Redmond
    Oregon
    97756
    United States
    Secretario
    1083 Highland View Loop
    Redmond
    Oregon
    97756
    United States
    British133502360001
    BUTCHER, Keith
    35 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    Secretario
    35 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    BritishFinance Director295528240001
    OGLE, Christopher John Rathmell
    Tedwood
    18 St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    Surrey
    Secretario
    Tedwood
    18 St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    Surrey
    BritishChartered Accountant41417240002
    PHILLIPS, David Peter
    5 Fairlands Road
    GU3 3JB Guildford
    Surrey
    Secretario
    5 Fairlands Road
    GU3 3JB Guildford
    Surrey
    British65269160001
    RICHARDSON, Ernest Arthur
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    British5161170001
    BABAN, Farzad
    8 Reed Avenue
    Westborough
    Ma 01581
    Usa
    Director
    8 Reed Avenue
    Westborough
    Ma 01581
    Usa
    UsPresident Us Oper.70287620001
    BUTCHER, Keith
    35 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    Director
    35 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    EnglandBritishFinance Director295528240001
    CARTER, Gary, Dr
    6 Fairview
    SO24 9PR Alresford
    Hampshire
    Director
    6 Fairview
    SO24 9PR Alresford
    Hampshire
    BritishDirector76022920001
    EVANDER, Lena Marie
    Hasselgarden Norrnas
    Varmdt
    139 50
    Sweden
    Director
    Hasselgarden Norrnas
    Varmdt
    139 50
    Sweden
    SwedishRegional Director94768350001
    EVANS, Barbara Beatrice
    Woodbine Cottage
    54 Green End Road, East Morton
    BD20 5TS Keighley
    West Yorkshire
    Director
    Woodbine Cottage
    54 Green End Road, East Morton
    BD20 5TS Keighley
    West Yorkshire
    BritishDevelopment Manager84029540002
    JOHNS, David Philip, Dr
    84 Woobly Road
    Bolton
    Ma 01740
    Usa
    Director
    84 Woobly Road
    Bolton
    Ma 01740
    Usa
    BritishDirector58364940003
    MANN, David William
    Theydon Copt Forest Side
    CM16 4ED Epping
    Essex
    Director
    Theydon Copt Forest Side
    CM16 4ED Epping
    Essex
    EnglandBritishManagement Consultant11201900001
    MCNAIR, Martin Alexander
    Highwood Lodge 31 Hampstead Lane
    N6 4RT London
    Director
    Highwood Lodge 31 Hampstead Lane
    N6 4RT London
    BritishInvestment Manager Venture Cap45711180001
    MOEZZI, Hassan
    235 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    Director
    235 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    United KingdomBritishDirector Business Dev92561820001
    MORRIS, Timothy Richard Thomas
    6 Embankment
    Putney
    SW15 1LB London
    Director
    6 Embankment
    Putney
    SW15 1LB London
    BritishAccountant47240180002
    OGLE, Christopher John Rathmell
    Tedwood
    18 St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    Surrey
    Director
    Tedwood
    18 St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant41417240002
    PHILLIPS, David Peter
    5 Fairlands Road
    GU3 3JB Guildford
    Surrey
    Director
    5 Fairlands Road
    GU3 3JB Guildford
    Surrey
    BritishAccountant65269160001
    RAMSHAW, Paul Stuart
    Lilac Cottage
    Furze Vale Road
    GU35 8EP Headley Down
    Hampshire
    Director
    Lilac Cottage
    Furze Vale Road
    GU35 8EP Headley Down
    Hampshire
    United KingdomBritishSales Exec88137260001
    REYNELL, Michael Jonathan Wilson, Doctor
    33 Arnison Road
    KT8 9JF East Molesey
    Surrey
    Director
    33 Arnison Road
    KT8 9JF East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritishSoftware Manufacturing38481960002
    RICHARDSON, Ernest Arthur
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    19 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Manager-Venture Cap5161170001
    ROSTEN, Harvey Ivor
    148 Elm Road
    KT3 3HT New Malden
    Surrey
    Director
    148 Elm Road
    KT3 3HT New Malden
    Surrey
    BritishComputer Specialist27949440001
    SHEIKHOLESLAMI, Zahed, Doctor
    11 Piccadilly Way
    01581 Westborough
    Ma
    Usa
    Director
    11 Piccadilly Way
    01581 Westborough
    Ma
    Usa
    IranianPresident54771520001
    TATCHELL, David George
    Courtlands
    Park Copse
    RH5 4BL Dorking
    Surrey
    Director
    Courtlands
    Park Copse
    RH5 4BL Dorking
    Surrey
    BritishMechanical Engineer45711320002

    ¿Tiene FLOMERICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 14 sept 2001
    Entregado el 20 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the legal charge
    Breve descripción
    The property k/a 76 bridge road, east molesey, KT8 9HF t/no SY246401 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property..assigns the related rights..by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery..by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future..assigns goodwill and intellectual property.
    Personas con derecho
    • Skipton Building Society
    Transacciones
    • 20 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 29 oct 1990
    Entregado el 15 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 1990Registro de una carga
    • 28 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creado el 12 jun 1989
    Entregado el 16 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1989Registro de una carga
    • 13 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0