MORRISON HOLDINGS LIMITED

MORRISON HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMORRISON HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02327554
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lancaster House Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BEALAW (234) LIMITED12 dic 198812 dic 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Estado de capital el 14 mar 2023

    • Capital: GBP 11.10
    5 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Interim dividend 09/03/2023
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Awg Shelf 11 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 feb 2022

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020

    6 páginasAA

    Nombramiento de Awg Corporate Services Limited como secretario el 22 feb 2021

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Elizabeth Ann Horlock Clarke como secretario el 22 feb 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Wayne Paul Young como director el 15 feb 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Jonathan David Forster el 29 jun 2020

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Awg Shelf 11 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 mar 2020

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Awg Shelf 11 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 ene 2019

    2 páginasPSC05

    Modification des détails de Awg Shelf 11 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 ene 2019

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AWG CORPORATE SERVICES LIMITED
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro12618899
    270129230001
    FORSTER, Jonathan David
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Director
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant101812460002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Director
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer105433380001
    YOUNG, Wayne Paul
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Director
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant264531200001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Secretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    198551290001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Secretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Secretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    ANDERSON, Mark Stephen
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Director
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director122463830003
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Director
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary203580340001
    CROSON, Roger Archibald
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    Director
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    BritishManaging Director4350003
    GREEN, Robert David
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    Director
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    BritishFinance Director76720550002
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Director
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritishCompany Director71318590003
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Director
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    BritishFinance Director1499960006
    MACLENNAN, Norman Angus
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    Director
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    BritishCompany Director75374210001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Director
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritishCompany Director33622580001
    MORRISON, Alexander Fraser, Sir Fraser Morrison
    Teasses House Nr Ceres
    KY8 5PG Leven
    Fife
    Director
    Teasses House Nr Ceres
    KY8 5PG Leven
    Fife
    United KingdomBritishDirector Of Companies4330002
    MORRISON, Gordon
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    Director
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector Of Companies1087030003
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Director
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishCompany Secretary1500260013
    ROBERTSON, Iain Alasdair
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Director
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    United KingdomBritishDirector63518980002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Director
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer105433380001
    VENABLES, Aileen Anderson
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    Director
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    United KingdomBritishSolicitor85155700001
    WARRACK, Anne Victoria Mary
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Director
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary123157220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Awg Shelf 11 Limited
    Capital Square
    58 Morrison Street
    EH3 8BP Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Capital Square
    58 Morrison Street
    EH3 8BP Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroUk
    Número de registroSc115080
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene MORRISON HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 07 abr 1992
    Entregado el 10 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 06 feb 1992
    Entregado el 20 feb 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 1992Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 11 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 mar 1989
    Entregado el 28 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 mar 1989Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0