GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02330098
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NC2 LIMITED16 ene 199216 ene 1992
    APPFIRE LIMITED20 dic 198820 dic 1988

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Shona Clare Searle como director el 01 jul 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Edward Dennison como director el 01 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 09 nov 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account of the company being £211,800 be cancelled and extinguished in full and it's credited to distributable reserves 26/10/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    19 páginasAA

    Segunda presentación para el nombramiento de James Edward Dennison como director

    3 páginasRP04AP01

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    18 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 páginasAD04

    Cambio de datos del director James Edward Dennison el 31 jul 2019

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Altair Filter Technology Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT el 31 jul 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Daryl Everett como director el 24 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de James Edward Dennison como director el 24 sept 2018

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    08 jun 2020Clarification A second filed AP01 was registered on 08/06/2020.

    Cese del nombramiento de Timothy Robert Hill como director el 24 sept 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro7038430
    146358090001
    SEARLE, Shona Clare
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish203330870002
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Secretario
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    American111641000001
    HEGARTY, Colin Michael
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    Secretario
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    British14062610002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYCE, Christian Jeremy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish174484350001
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Director
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    American111641000001
    CARSON, Candace
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    Director
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    American111758740001
    CHURCH, Ian Harold
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    Director
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    British1750390002
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish56868460002
    CLEAVER, Roy Edward
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    Director
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    British21416960002
    DENNISON, James Edward
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish250786800001
    ELSDON, Peter John
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Director
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish67751830001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish127244240001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish127244240001
    HEINTZELMAN, Daniel
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    Director
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    American111641060001
    HILL, Timothy Robert
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish183650700001
    HINTON, David Ian Small
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    Director
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish21416950001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Director
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    British106985300001
    RICHARDSON, Paul
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish174494740001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritish203364460001
    SENNETT, Paul Timothy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish174484310001
    STEEL, Andrew Charles
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    Director
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    EnglandBritish33164070002
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish96648390001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4543176
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    29 nov 201601 dic 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H interest in plot 3, omega park, wilsom road, alton, hampshire t/n HP481527. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The South Place Gresham Partnership 2002 Acting as Security Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 feb 2003
    Entregado el 07 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Freehold property known as plot 3 omega park wilsom road alton hampshire t/n HP481527. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 feb 2003
    Entregado el 07 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Stock pledge
    Creado el 01 feb 2003
    Entregado el 07 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The entire issued share capital of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 07 abr 1994
    Entregado el 18 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot 3 omega park alton hampshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 sept 1989
    Entregado el 25 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1989Registro de una carga
    • 05 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 sept 1989
    Entregado el 02 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 1989Registro de una carga
    • 05 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0