CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02345676 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
- Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Concept Life Sciences Frith Knoll Road SK23 0PG Chapel-En-Le-Frith High Peak England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PEAKDALE MOLECULAR LIMITED | 30 jul 2001 | 30 jul 2001 |
| PEAKDALE TECHNOLOGIES LIMITED | 21 nov 2000 | 21 nov 2000 |
| PEAKDALE FINE CHEMICALS LIMITED | 26 oct 1992 | 26 oct 1992 |
| RESEARCH INTERMEDIATES LIMITED | 09 feb 1989 | 09 feb 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Benjamin Cliff como director el 10 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 23 páginas | AA | ||
legacy | 40 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Timothy Critchley como director el 29 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 23 páginas | AA | ||
legacy | 39 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Registro de la carga 023456760007, creada el 19 nov 2024 | 48 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022 | 26 páginas | AA | ||
legacy | 183 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Warwick House 25-27 Buckingham Palace Road London SW1W 0PP England a Concept Life Sciences Frith Knoll Road Chapel-En-Le-Frith High Peak SK23 0PG el 24 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Limerston Capital 12-18 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH England a Warwick House 25-27 Buckingham Palace Road London SW1W 0PP el 05 abr 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Steven Blair como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Dr Benjamin Cliff como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITCHLEY, Jonathan Timothy | Director | Frith Knoll Road SK23 0PG Chapel-En-Le-Frith Concept Life Sciences High Peak England | England | British | 328643350001 | |||||
| DEANE, Lynn Allison | Secretario | Reflections 7 Warrens Field PL32 9YX Camelford Cornwall | British | 23348210001 | ||||||
| FISHER, Christine | Secretario | Peakdale Science Park Sheffield Road SK23 0PG Chapel En Le Frith High Peak | 171591890001 | |||||||
| MCCLUSKEY, Paul | Secretario | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 | 191755550001 | |||||||
| SMITH, Graeme Richard | Secretario | Pine Trees 2a Manchester Road WA16 0NT Knutsford Cheshire | British | 47291680006 | ||||||
| THORPE, Jane Elizabeth | Secretario | The Old Stables 1 Dakin Court Lesser Lane Waterswallows Road SK17 7JL Buxton | British | 30833880003 | ||||||
| BLAIR, Steven | Director | 12-18 Grosvenor Gardens SW1W 0DH London Limerston Capital England | United Kingdom | British | 299848800001 | |||||
| CARNEGIE-BROWN, Mark, Dr | Director | Block 35s Alderley Park SK10 4TG Cheshire C/O Concept Life Sciences United Kingdom | United Kingdom | British | 224430380001 | |||||
| CAVALLA, David John, Dr | Director | 5 Tenison Avenue CB1 2DX Cambridge | England | British | 37933740001 | |||||
| CLIFF, Benjamin, Dr | Director | Frith Knoll Road SK23 0PG Chapel-En-Le-Frith Concept Life Sciences High Peak England | England | British | 307555740001 | |||||
| DEANE, Christopher Colin | Director | Reflections 7 Warrens Field PL32 9YS Camelford Cornwall | British | 14704020001 | ||||||
| DOYLE, Paul Martin, Dr | Director | Cautley Road LS10 5LT Sedbergh Burnt Mill Cumbria | United Kingdom | British | 191993200001 | |||||
| DOYLE, Paul Martin, Dr | Director | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 | United Kingdom | British | 191993200001 | |||||
| FISHER, Christine | Director | 11 Broad Walk SK17 6JR Buxton Cavendish House | England | British | 47530380004 | |||||
| FISHER, Raymond, Dr | Director | Cavendish House 11 Broad Walk SK17 6JR Buxton | England | British | 23348220005 | |||||
| FORT, Michael John | Director | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 189303790003 | |||||
| FRASER ALLEN, William Thomas | Director | c/o C/O Albion Ventures Llp King's Arms Yard EC2R 7AF London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 99989230002 | |||||
| GRACEY, Patrick | Director | Peakdale Science Park Sheffield Road SK23 0PG Chapel En Le Frith High Peak | England | British | 178799380001 | |||||
| HANDLEY, John William | Director | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 236950100001 | |||||
| HANSON, Matthew James | Director | Church Road TW20 9QD Egham Heritage House England | United Kingdom | British | 276583410001 | |||||
| HART, Terance William, Dr | Director | 12 Perry Court Clerk Maxwell Road CB3 0RS Cambridge Cambridgeshire | England | British | 64902370002 | |||||
| HORDER, Steven Francis Axtell | Director | 5th Floor, 44-46 Aldwych WC2B 4LL London Melbourne House England | United Kingdom | British | 271429910002 | |||||
| JOYCE, Paul Richard | Director | 1 Mission View Arrunden HD9 2TN Holmfirth | England | British | 60267050004 | |||||
| MASTERMAN, Richard Thomas | Director | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | British | 3437250001 | ||||||
| MAUDSLEY, Clive Stewart | Director | M3 4EH Manchester Flat B 12-3 1 Watson Street England | United Kingdom | British | 142412520001 | |||||
| MCCLUSKEY, Paul | Director | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 156519370001 | |||||
| MCGOUN, Michael Frederick | Director | The Old Rectory Church Lane Mobberley WA16 7RD Knutsford Cheshire | England | British | 8300340001 | |||||
| MORGAN, Alan Stuart | Director | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 | England | British | 72916280001 | |||||
| MORRISON, Kimberley Ann | Director | Woodlands 20 Lismore Road SK17 9AZ Buxton Derbyshire | British | 25238880002 | ||||||
| RICHARDS, Raymond David | Director | 3 Hillhead Gardens PL32 9TD Camelford Cornwall | British | 4379860001 | ||||||
| SMITH, Graeme Richard | Director | Pine Trees 2a Manchester Road WA16 0NT Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 47291680006 | |||||
| WHITELEY, Angus Oliver | Director | 32 Richford Street W6 7HP London | England | British | 102361840002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CONCEPT LIFE SCIENCES INTEGRATED DISCOVERY & DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept Life Sciences (Discovery) Limited | 06 abr 2016 | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0