NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02353847
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Princes Street
    EC2R 8PB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LOMBARD INDUSTRIAL FINANCE LIMITED13 abr 198913 abr 1989
    CHASEART LIMITED01 mar 198901 mar 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Alan Piers Johnson el 13 oct 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 14 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 jun 2015

    Estado de capital el 22 jun 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Nombramiento de Mr Alan Piers Johnson como director el 11 may 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Paul Gadsby como director el 11 may 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 1

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    11 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Nigel Timothy John Clibbens como director el 27 feb 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jun 2014

    Estado de capital el 02 jun 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nombramiento de Mr Andrew Paul Gadsby como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Trevor Douglas Crome como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nigel Timothy John Clibbens como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Julian Rogers como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roy Warren como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Sullivan como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mrs Sharon Jill Caterer el 23 jun 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Rbs Secretarial Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Carolyn Down como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    22 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secretario corporativo
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC269847
    169073830001
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Director
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritishAccountant15490360001
    CROME, Trevor Douglas
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    Director
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    EnglandBritishBank Official186705800001
    JOHNSON, Alan Piers
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    Director
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Offical155895050001
    BARTLETT, Paul Eugene
    40 Catherine Street
    AL3 5BU St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    40 Catherine Street
    AL3 5BU St Albans
    Hertfordshire
    British54206450003
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Secretario
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Other67499700004
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secretario
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    BritishCompany Secretary2289880001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secretario
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    BritishCompany Secretary2289880001
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Secretario
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    British34423910002
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Secretario
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Secretario
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    BAILEY, Richard James
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Director
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    BritishBanker37824840001
    BARTON-SMITH, Colim
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishBanker23187320002
    BRODIE, Robert Duncan
    Flat 61 Saint Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    Director
    Flat 61 Saint Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    BritishStrategist67734620004
    BULL, Richard Piers Ashworth
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    BritishBank Executive34371520003
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Director
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Banker53756030002
    CARTE, Brian Addison
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Director
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishBanker145559220001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Director
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    Director
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    United KingdomBritishChartered Accountant49141230004
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritishBank Executive96202910001
    DENT, Nicholas Michael
    4 Acacia Road
    TW18 1BY Staines
    Middlesex
    Director
    4 Acacia Road
    TW18 1BY Staines
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant43922780002
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Director
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    BritishHead Of Risk & Portfolio Manag96634670001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant43015720002
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    Director
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    BritishDeputy Chief Executive8461210001
    FLINT, Eion Arthur Mcmorran
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Director56760630002
    GADSBY, Andrew Paul
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    Director
    Princes Street
    EC2R 8PB London
    1
    EnglandBritishBank Official74834980002
    HENDERSON CLELAND, Hugh John
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    Director
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    BritishBanker57536880001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Director
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritishFinance House Manager107984310001
    HILLIARD, Adrian Richard
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    Director
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    BritishInvestment Banker49021840001
    HING, Allen Peter
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    Director
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    BritishBanker11403910001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Director
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    BritishAccountant103077710001
    KEIGHLEY, Peter Thomas
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Director
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishBanker43234170001
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    BritishBank Executive67501900002

    ¿Tiene NATWEST INDUSTRIAL FINANCE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 31 dic 1993
    Entregado el 10 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The secured obligations of the company to the chargee (as agent and trustee for the beneficiary) on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title & interest to & in the aircraft being boeing 747-400 reg mark vr-hug inc, any replacement engines or parts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Internationale Nederlanden Aviation Lease Bv
    Transacciones
    • 10 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Account pledge
    Creado el 16 dic 1993
    Entregado el 04 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The secured liabilities due from the company to the chargee (as defined in the charge)
    Breve descripción
    All right title & interest in & to the pledged assets being the deposit meaning all moneys standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • Internationale Nederlanden Aviation Lease Bvas Trustee for Itself, the Agent and the Lenders (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 04 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0