CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED

CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02355338
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    • Instalación eléctrica (43210) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Abbey Orchard Street
    SW1P 2HT London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES SE LIMITED02 ene 200302 ene 2003
    EASTERN CONTRACTING LIMITED26 nov 199726 nov 1997
    EASTERN ELECTRICITY CONTRACTING LIMITED20 feb 199520 feb 1995
    EASTERN CONTRACTORS LIMITED15 may 198915 may 1989
    WOODHELM LIMITED06 mar 198906 mar 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2017
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2018
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 mar 2019
    Próxima declaración de confirmación vence15 mar 2019
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 mar 2018
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT el 03 oct 2018

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion Utility Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 09 ago 2018

    1 páginasTM02

    Orden del tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nigel Paul Taylor como director el 29 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Adam Green como director el 18 sept 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Alan Hayward como director el 06 ene 2017

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Richard John Adam como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 31 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 mar 2016

    Estado de capital el 01 mar 2016

    • Capital: GBP 20,100,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    18 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Alan Hayward el 02 mar 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Nigel Paul Taylor el 17 mar 2015

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ELLIS, Philip Arthur
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    Secretario
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    British301940002
    ELLIS, Philip Arthur
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    Secretario
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    British301940002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Other137329800003
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Secretario
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    LEE, Christopher Michael
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    Secretario
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    British133709330001
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235183590001
    MAYES, Andrew Paul
    Sanders Close
    Little Stukeley
    PE28 4BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    Sanders Close
    Little Stukeley
    PE28 4BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    British56257310002
    SWEET, Simon Andrew
    The Hollies Norwich Road
    Claydon
    IP6 0DQ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    The Hollies Norwich Road
    Claydon
    IP6 0DQ Ipswich
    Suffolk
    British44971370001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    BOOTH, Karen Jane
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish192636860001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Director
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Director
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    COCLIFF, Stephen Jeffrey
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    Director
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    EnglandBritish125427070002
    DEVANEY, John Francis
    Kettleshill Farm
    Under River
    TN15 0RX Sevenoaks
    Kent
    Director
    Kettleshill Farm
    Under River
    TN15 0RX Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish30106190004
    DODSON, Michael George
    The Old Vicarage
    Fulford
    ST11 9QS Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    The Old Vicarage
    Fulford
    ST11 9QS Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish91520610001
    ELLIS, Philip Arthur
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    Director
    111 Church Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2LB Chelmsford
    Essex
    British301940002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill, Goring Heath
    RG8 7RE Oxfordshire
    Director
    Pilgrim Cottage
    Path Hill, Goring Heath
    RG8 7RE Oxfordshire
    EnglandBritish38750850004
    GREEN, Adam Richard
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish129918780001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Director
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    HAYWARD, Alan
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154549030001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Director
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Director
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    JONES, Mark Richard
    The Old School School Lane
    Coveney
    CB6 2DB Ely
    Cambridgeshire
    Director
    The Old School School Lane
    Coveney
    CB6 2DB Ely
    Cambridgeshire
    British56258070002
    JONES, Peter Rudulph
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandIrish173952430001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Director
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LEAN, Edward Jonathan
    58 Wimpole Road
    CB3 7AB Barton
    Cambridge
    Director
    58 Wimpole Road
    CB3 7AB Barton
    Cambridge
    British99953640001
    LEDWIDGE, Joseph John
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    Director
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    United KingdomBritish105384920001
    MARSH, Paul Colin
    28 Maynards
    Whittlesford
    CB2 4PN Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    28 Maynards
    Whittlesford
    CB2 4PN Cambridge
    Cambridgeshire
    British48380310001
    MAYES, Andrew Paul
    Sanders Close
    Little Stukeley
    PE28 4BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Sanders Close
    Little Stukeley
    PE28 4BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish56257310002
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Director
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MERCER, Emma
    Cottage
    Lawnhead
    ST20 0JQ Stafford
    Ivy
    Staffordhire
    United Kingdom
    Director
    Cottage
    Lawnhead
    ST20 0JQ Stafford
    Ivy
    Staffordhire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137321980002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01521006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 30 abr 1999
    Entregado el 18 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a the eastern electricity depot blackstone road stukeley meadows huntingdon cambridgeshire t/n CB122303. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 01 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 1998
    Entregado el 03 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and eastern contracting (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a former british gas depot moreton hall industrial estate bury st edmunds suffolk. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 01 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 ene 1998
    Entregado el 06 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 01 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 abr 2018Fecha de la petición
    13 jun 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0