CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02355338 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
- Instalación eléctrica (43210) / Construcción
¿Dónde se encuentra CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES SE LIMITED | 02 ene 2003 | 02 ene 2003 |
| EASTERN CONTRACTING LIMITED | 26 nov 1997 | 26 nov 1997 |
| EASTERN ELECTRICITY CONTRACTING LIMITED | 20 feb 1995 | 20 feb 1995 |
| EASTERN CONTRACTORS LIMITED | 15 may 1989 | 15 may 1989 |
| WOODHELM LIMITED | 06 mar 1989 | 06 mar 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2019 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 mar 2019 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2018 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT el 03 oct 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion Utility Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 09 ago 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Orden del tribunal para liquidar | 2 páginas | COCOMP | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Paul Taylor como director el 29 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Green como director el 18 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Hayward como director el 06 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Adam como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 31 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Alan Hayward el 02 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Paul Taylor el 17 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIS, Philip Arthur | Secretario | 111 Church Road Hatfield Peverel CM3 2LB Chelmsford Essex | British | 301940002 | ||||||
| ELLIS, Philip Arthur | Secretario | 111 Church Road Hatfield Peverel CM3 2LB Chelmsford Essex | British | 301940002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Secretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | Other | 137329800003 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Secretario | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183590001 | |||||||
| MAYES, Andrew Paul | Secretario | Sanders Close Little Stukeley PE28 4BX Huntingdon Cambridgeshire | British | 56257310002 | ||||||
| SWEET, Simon Andrew | Secretario | The Hollies Norwich Road Claydon IP6 0DQ Ipswich Suffolk | British | 44971370001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BOOTH, Karen Jane | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Director | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| COCKER, Neil David | Director | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Director | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| DEVANEY, John Francis | Director | Kettleshill Farm Under River TN15 0RX Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 30106190004 | |||||
| DODSON, Michael George | Director | The Old Vicarage Fulford ST11 9QS Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 91520610001 | |||||
| ELLIS, Philip Arthur | Director | 111 Church Road Hatfield Peverel CM3 2LB Chelmsford Essex | British | 301940002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Director | Pilgrim Cottage Path Hill, Goring Heath RG8 7RE Oxfordshire | England | British | 38750850004 | |||||
| GREEN, Adam Richard | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 129918780001 | |||||
| GRICE, Ian Michael | Director | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HAYWARD, Alan | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Director | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Director | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Mark Richard | Director | The Old School School Lane Coveney CB6 2DB Ely Cambridgeshire | British | 56258070002 | ||||||
| JONES, Peter Rudulph | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEAN, Edward Jonathan | Director | 58 Wimpole Road CB3 7AB Barton Cambridge | British | 99953640001 | ||||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Director | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| MARSH, Paul Colin | Director | 28 Maynards Whittlesford CB2 4PN Cambridge Cambridgeshire | British | 48380310001 | ||||||
| MAYES, Andrew Paul | Director | Sanders Close Little Stukeley PE28 4BX Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 56257310002 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Director | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MERCER, Emma | Director | Cottage Lawnhead ST20 0JQ Stafford Ivy Staffordhire United Kingdom | United Kingdom | British | 137321980002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Utility Services Group Limited | 06 abr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 30 abr 1999 Entregado el 18 may 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property k/a the eastern electricity depot blackstone road stukeley meadows huntingdon cambridgeshire t/n CB122303. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 jul 1998 Entregado el 03 jul 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and eastern contracting (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold property k/a former british gas depot moreton hall industrial estate bury st edmunds suffolk. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 ene 1998 Entregado el 06 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES S.E. LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0