DISTRICT ENERGY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DISTRICT ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02362017 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DISTRICT ENERGY LIMITED?
- Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
¿Dónde se encuentra DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court B91 2AA Solihull England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED | 19 mar 1999 | 19 mar 1999 |
| BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED | 26 feb 1999 | 26 feb 1999 |
| NE GENERATION LIMITED | 16 feb 1994 | 16 feb 1994 |
| NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD. | 06 abr 1990 | 06 abr 1990 |
| SIGNKIT LIMITED | 16 mar 1989 | 16 mar 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Robert Koss como director el 03 ago 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nauman Ahmad como director el 03 ago 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sam Kieron Wither como director el 30 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 páginas | AD03 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 páginas | AD02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Paul David Tomlinson como director el 30 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England a 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA el 18 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Christopher Hands como secretario el 01 abr 2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS el 18 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Joseph Mountford como secretario el 01 abr 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 17 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Paul David Tomlinson como director el 12 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sriram Narayanan como director el 12 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Peter Addis como director el 31 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 023620170007 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 023620170008 | 1 páginas | MR04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Christopher Hands como director el 31 may 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDS, Stephen Christopher | Secretario | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | 257684290001 | |||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Director | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 205116300001 | |||||
| KOSS, Andrew Robert | Director | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | England | English | 157160710002 | |||||
| ALLEN, Anthony | Secretario | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secretario | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secretario | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| GRANT, Paul Robert | Secretario | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | 170448160001 | |||||||
| LAWRIE, Karen Nicola | Secretario | Bishops Frome WR6 5AS Worcester Boscombe House Worcestershire | British | 138732390001 | ||||||
| MELVILLE, John Rex | Secretario | Haileywood 3 Birchen Lane RH16 1RY Haywards Heath West Sussex | British | 12057640001 | ||||||
| MOUNTFORD, Andrew Joseph | Secretario | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | 244885560001 | |||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secretario | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secretario | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Director | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | England | British | 260439420001 | |||||
| AHMAD, Nauman | Director | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | Pakistani | 246516040001 | |||||
| ALLEN, Anthony | Director | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Director | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | United Kingdom | British | 50003350005 | |||||
| BERESFORD, Nigel Stephen | Director | c/o Edf Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 England | United Kingdom | English | 140458520001 | |||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Director | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BLISS, Simon Richard Weston | Director | Edgehill West Glen Road PA13 4PH Kilmalcolm | Scotland | British | 82638440001 | |||||
| BROOKSHAW, Terry | Director | Saddlers Field Bowbridge Lane, Prestbury GL52 3BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 78425070001 | ||||||
| CLEMENTS, Andrew Arthur | Director | 27 Grange Court Road Westbury On Trym BS9 4DR Bristol | British | 52249820001 | ||||||
| COLEY, William Alfred | Director | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 90266090006 | ||||||
| DOWN, Leonard Michael | Director | 6 King Malcolm Close EH10 7JB Edinburgh | British | 58057730001 | ||||||
| EMRICH, Timothy Wayne | Director | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | United Kingdom | American | 159180900001 | |||||
| HOLLINS, Peter Thomas | Director | 10d Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh | British | 56803330002 | ||||||
| JEFFREY, Robin Campbell, Dr | Director | 71d Partickhill Road G11 5AD Glasgow | British | 34426500002 | ||||||
| JOHNSON, Christopher Brian | Director | 31 Merevale Road GL2 0QX Gloucester | United Kingdom | British | 46900180001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Director | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Director | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Director | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LANGLEY, Michael James | Director | 13 Nelson Street EH3 6LF Edinburgh Midlothian | British | 70818670002 | ||||||
| LOUGH, Keith Geddes | Director | Lochside PA12 4JH Lochwinnoch Renfrewshire | United Kingdom | British | 101630860001 | |||||
| LOW, Michael Brian John | Director | Grange House Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 76638420001 | ||||||
| MACDONALD, Jean Elizabeth | Director | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | Scotland | British | 4947170004 | |||||
| MARSHALL, Richard Allan Jeffrey | Director | c/o British Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 151085170001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Power Reserve Ltd | 06 abr 2016 | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DISTRICT ENERGY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 16 nov 2015 Entregado el 20 nov 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 16 nov 2015 Entregado el 19 nov 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 13 ago 2014 Entregado el 20 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 13 ago 2014 Entregado el 20 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 ene 2005 Entregado el 17 ene 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of amendment | Creado el 28 nov 2002 Entregado el 16 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 sept 2002 Entregado el 09 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0