DISTRICT ENERGY LIMITED

DISTRICT ENERGY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDISTRICT ENERGY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02362017
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    • Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

    ¿Dónde se encuentra DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6th Floor, Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED19 mar 199919 mar 1999
    BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED26 feb 199926 feb 1999
    NE GENERATION LIMITED16 feb 199416 feb 1994
    NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD.06 abr 199006 abr 1990
    SIGNKIT LIMITED16 mar 198916 mar 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Andrew Robert Koss como director el 03 ago 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nauman Ahmad como director el 03 ago 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Sam Kieron Wither como director el 30 nov 2019

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul David Tomlinson como director el 30 sept 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England a 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA el 18 abr 2019

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Stephen Christopher Hands como secretario el 01 abr 2019

    2 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA a Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS el 18 abr 2019

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Andrew Joseph Mountford como secretario el 01 abr 2019

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    17 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul David Tomlinson como director el 12 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sriram Narayanan como director el 12 feb 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Peter Addis como director el 31 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 023620170007

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 023620170008

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Stephen Christopher Hands como director el 31 may 2018

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HANDS, Stephen Christopher
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Secretario
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    257684290001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish205116300001
    KOSS, Andrew Robert
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Director
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    EnglandEnglish157160710002
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Secretario
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secretario
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secretario
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    GRANT, Paul Robert
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Secretario
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    170448160001
    LAWRIE, Karen Nicola
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    Secretario
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    British138732390001
    MELVILLE, John Rex
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    Secretario
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    British12057640001
    MOUNTFORD, Andrew Joseph
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Secretario
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    244885560001
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    ADDIS, Jonathan Peter
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Director
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    EnglandBritish260439420001
    AHMAD, Nauman
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandPakistani246516040001
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Director
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Director
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish50003350005
    BERESFORD, Nigel Stephen
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    Director
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    United KingdomEnglish140458520001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Director
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BLISS, Simon Richard Weston
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    Director
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    ScotlandBritish82638440001
    BROOKSHAW, Terry
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British78425070001
    CLEMENTS, Andrew Arthur
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    Director
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    British52249820001
    COLEY, William Alfred
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Director
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British90266090006
    DOWN, Leonard Michael
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Director
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British58057730001
    EMRICH, Timothy Wayne
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Director
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    United KingdomAmerican159180900001
    HOLLINS, Peter Thomas
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Director
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    British56803330002
    JEFFREY, Robin Campbell, Dr
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Director
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    British34426500002
    JOHNSON, Christopher Brian
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    Director
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    United KingdomBritish46900180001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Director
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Director
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KUSTERER, Thomas Andreas
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Director
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomGerman137548090001
    LANGLEY, Michael James
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    British70818670002
    LOUGH, Keith Geddes
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Director
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritish101630860001
    LOW, Michael Brian John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British76638420001
    MACDONALD, Jean Elizabeth
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Director
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    ScotlandBritish4947170004
    MARSHALL, Richard Allan Jeffrey
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Director
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish151085170001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    06 abr 2016
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro7385282
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene DISTRICT ENERGY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 nov 2015
    Entregado el 20 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transacciones
    • 20 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 16 ene 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 nov 2015
    Entregado el 19 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 16 ene 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 13 ago 2014
    Entregado el 20 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 20 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 19 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 13 ago 2014
    Entregado el 20 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 20 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 19 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 ene 2005
    Entregado el 17 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nuclear Generation Decommissioning Fund Limited
    Transacciones
    • 17 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 27 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of amendment
    Creado el 28 nov 2002
    Entregado el 16 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 16 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 sept 2002
    Entregado el 09 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 09 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0