ARRIVA DERBY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ARRIVA DERBY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02362274 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ARRIVA DERBY LIMITED?
- Otros transportes terrestres de pasajeros urbano, suburbano o metropolitano (no metro ni sistemas similares) (49319) / Transporte y almacenamiento
- Operación de taxis (49320) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra ARRIVA DERBY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York North Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DERBY CITY TRANSPORT LIMITED | 15 sept 1989 | 15 sept 1989 |
| DARTPINE LIMITED | 16 mar 1989 | 16 mar 1989 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ARRIVA DERBY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARRIVA DERBY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Modification des détails de Arriva (2007) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 nov 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG el 14 mar 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon William Mathieson como director el 27 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 27 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert James Cheveaux como director el 27 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Antony Bowd como director el 27 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Lorna Edwards como director el 27 jun 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mark Antony Bowd como director el 22 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Charles Barlow como director el 27 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Donald Perry como director el 31 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark David James Yexley como director el 03 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Simon William Mathieson el 28 abr 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Evans como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, Lorna | Secretario | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | 183720730001 | |||||||
| EDWARDS, Lorna | Director | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | England | British | 205425080001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Secretario | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| DAVIES, Elizabeth Anne | Secretario | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| JARRATT, Andrew Howard | Secretario | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | British | 1860730001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Secretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Secretario corporativo | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BARLOW, John Charles | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 66466620003 | |||||
| BAXTER, Barry James | Director | 5 Denver Fold ST17 9XE Stafford Staffordshire | British | 83122700001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Director | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Director | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BICKLE, Kenneth | Director | Langton Cottage Roston DE6 2EH Ashbourne Derbyshire | British | 3036960002 | ||||||
| BOWD, Mark Antony | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWD, Mark Antony | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 35116070003 | |||||
| BOWLER, Richard Charles | Director | 23b Brazenose Driftway Cowley OX4 2QY Oxford | British | 51739150001 | ||||||
| CHALLANDS, John Frank | Director | 218 Caxton Street Sunnyhill DE23 7RB Derby Derbyshire | British | 12008050001 | ||||||
| CHEVEAUX, Robert James | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | Wales | British | 182114820001 | |||||
| CLARKE, Kenneth Barry | Director | 2 Sherwood Drive WF2 7QT Wakefield West Yorkshire | British | 76952760002 | ||||||
| CLAYTON, Stephen John | Director | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| CUMMING, Graham Jackson | Director | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | 22410440002 | ||||||
| DYBALL, Richard Charles | Director | 110 Upper Harlestone NN7 4EL Northampton | British | 33781930001 | ||||||
| EDGE, Christopher | Director | 46 Howards Lane Putney SW15 6NJ London | British | 11465390001 | ||||||
| EVANS, Matthew John | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 197082950001 | |||||
| HARVEY, Peter | Director | Chapel End 36 Main Street Swithland LE12 8TH Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 30318040003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 21961900003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Director | 173 Station Road Cropston LE7 7HH Leicester Leicestershire | British | 21961900001 | ||||||
| HOPKINS, Christian | Director | Whitehill Avenue LU1 3SP Luton 46 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 248192360001 | |||||
| JARRATT, Andrew Howard | Director | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 1860730001 | |||||
| JOHNSTONE, David Graham | Director | 7 Pont Haugh Eland Mews Ponteland NE20 9XD Newcastle Upon Tyne | British | 95834280001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Director | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LLOYD, Alfred | Director | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 131555780001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Director | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Director | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Director | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ARRIVA DERBY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Uk Bus Holdings Limited | 06 abr 2016 | Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ARRIVA DERBY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 10 oct 2008 Entregado el 17 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 09 sept 1994 Entregado el 23 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 09 sept 1994 Entregado el 23 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge, | |
Breve descripción All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of charge and set-off over credit balances | Creado el 15 ago 1994 Entregado el 31 ago 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Breve descripción All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 27 ago 1993 Entregado el 07 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £81,585 due under the agreement | |
Breve descripción All rights,title and interest in all sums payable.see form 395. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A credit agreement | Creado el 14 sept 1992 Entregado el 24 sept 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £72203.04 under the agreement | |
Breve descripción All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 25 ago 1989 Entregado el 14 sept 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ARRIVA DERBY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0