ARRIVA DERBY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARRIVA DERBY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02362274
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARRIVA DERBY LIMITED?

    • Otros transportes terrestres de pasajeros urbano, suburbano o metropolitano (no metro ni sistemas similares) (49319) / Transporte y almacenamiento
    • Operación de taxis (49320) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra ARRIVA DERBY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARRIVA DERBY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DERBY CITY TRANSPORT LIMITED15 sept 198915 sept 1989
    DARTPINE LIMITED16 mar 198916 mar 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARRIVA DERBY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARRIVA DERBY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Modification des détails de Arriva (2007) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 nov 2017

    2 páginasPSC05

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG el 14 mar 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 feb 2017

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Simon William Mathieson como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert James Cheveaux como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Antony Bowd como director el 27 jun 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Lorna Edwards como director el 27 jun 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 10 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2016

    Estado de capital el 10 mar 2016

    • Capital: GBP 3,108,173
    SH01

    Nombramiento de Mark Antony Bowd como director el 22 ene 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Charles Barlow como director el 27 nov 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alexander Donald Perry como director el 31 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark David James Yexley como director el 03 jul 2015

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Simon William Mathieson el 28 abr 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 10 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2015

    Estado de capital el 10 mar 2015

    • Capital: GBP 3,108,173
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    19 páginasAA

    Cese del nombramiento de Matthew Evans como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 10 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2014

    Estado de capital el 10 mar 2014

    • Capital: GBP 3,108,173
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de ARRIVA DERBY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Secretario
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183720730001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Director
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritish205425080001
    BOWLER, Richard Anthony
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    Secretario
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    British35116070001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    British1860730001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BARLOW, John Charles
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish66466620003
    BAXTER, Barry James
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    Director
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    British83122700001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BICKLE, Kenneth
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    British3036960002
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish35116070003
    BOWLER, Richard Charles
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    Director
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    British51739150001
    CHALLANDS, John Frank
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    Director
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    British12008050001
    CHEVEAUX, Robert James
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    WalesBritish182114820001
    CLARKE, Kenneth Barry
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    British76952760002
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Director
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Director
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    DYBALL, Richard Charles
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Director
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    British33781930001
    EDGE, Christopher
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    Director
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    British11465390001
    EVANS, Matthew John
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish197082950001
    HARVEY, Peter
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    Director
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish30318040003
    HIND, Robert Andrew
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish21961900003
    HIND, Robert Andrew
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    Director
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    British21961900001
    HOPKINS, Christian
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish248192360001
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish1860730001
    JOHNSTONE, David Graham
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    Director
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    British95834280001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Director
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LLOYD, Alfred
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish131555780001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Director
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ARRIVA DERBY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    06 abr 2016
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4166672
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ARRIVA DERBY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 10 oct 2008
    Entregado el 17 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 09 sept 1994
    Entregado el 23 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transacciones
    • 23 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 09 sept 1994
    Entregado el 23 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge,
    Breve descripción
    All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston,
    Transacciones
    • 23 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 01 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creado el 15 ago 1994
    Entregado el 31 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descripción
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 27 ago 1993
    Entregado el 07 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £81,585 due under the agreement
    Breve descripción
    All rights,title and interest in all sums payable.see form 395.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 07 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A credit agreement
    Creado el 14 sept 1992
    Entregado el 24 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £72203.04 under the agreement
    Breve descripción
    All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limted
    Transacciones
    • 24 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 25 ago 1989
    Entregado el 14 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 1989Registro de una carga
    • 16 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ARRIVA DERBY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 feb 2017Inicio de la liquidación
    25 dic 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Profesional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0