DCS AUTOMOTIVE LIMITED

DCS AUTOMOTIVE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDCS AUTOMOTIVE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02377414
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLOBAL AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED06 jun 199706 jun 1997
    DCS UK HOLDINGS LIMITED12 sept 199412 sept 1994
    MOTIS LIMITED06 nov 199006 nov 1990
    TRADESTAGS LIMITED28 abr 198928 abr 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 09 ene 2012

    • Capital: GBP 1.5
    4 páginasSH19

    legacy

    4 páginasSH20

    legacy

    5 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 dic 2011

    • Capital: GBP 15,056,010
    3 páginasSH01

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Terry Wallace Jones como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Carlan Cooper como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Norman Tommy Barras como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert Theron Brockman como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Dan Steven Agan como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Robert Maxey Nalley como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Moss como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    11 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas190

    ¿Quiénes son los directivos de DCS AUTOMOTIVE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Secretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    AGAN, Dan Steven
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    United StatesAmerican84053880001
    BARRAS, Norman Tommy
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    United StatesAmerican84053860001
    BROCKMAN, Robert Theron
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    United StatesAmerican158497330001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Director
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    COOPER, Carlan Max
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    UsaUnited States136536270001
    JONES, Terry Wallace
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    United StatesAmerican84053830001
    NALLEY, Robert Maxey
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    Director
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    United Kingdom
    United StatesAmerican84053700001
    BATE, Nicholas John
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    Secretario
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    British10672220001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Secretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Secretario
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Director
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    Director
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Director
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritish89866330001
    EMBLEY, Paul
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    Director
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    British66065980001
    FLEGG, Ronald Edwin
    14 Worthington Close
    Henbury
    SK11 9NS Macclesfield
    Cheshire
    Director
    14 Worthington Close
    Henbury
    SK11 9NS Macclesfield
    Cheshire
    British10672250001
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish64591610001
    GESWEIN, Gregory Thomas
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    Director
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    American114993100001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Director
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    British94654870001
    HARRISON, Jeffrey Malcolm
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    British16150470002
    LAWSON, Nicholas St John
    Ashton Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    Director
    Ashton Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    EnglandBritish43842220001
    MACKENZIE, Iain Robertson
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    Director
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    British35613150001
    MARTIN, Robert Edward
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    Director
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish24767980001
    MERRIMAN, Christopher Peter
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    Director
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    British63578740002
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Director
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Director
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    SOANES, David
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    Director
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    British80021380001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Director
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    British46677090001
    VENTURA, Douglas Michael
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    Director
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    American111985510001
    WOODALL, Frederick Peter
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    Director
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    British74795530001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Director
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish42686850001

    ¿Tiene DCS AUTOMOTIVE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 oct 2005
    Entregado el 21 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 31 mar 2004
    Entregado el 01 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 05 jun 2000
    Entregado el 13 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 ene 1995
    Entregado el 27 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0