SEVERN RIVER CROSSING PLC

SEVERN RIVER CROSSING PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSEVERN RIVER CROSSING PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02379695
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Dirección de la sede social
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEGIBUS 1390 LIMITED04 may 198904 may 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta08 ene 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 dic 2019

    11 páginasLIQ03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Bridge Access Road Aust Bristol BS35 4BD

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Bridge Access Road Aust Bristol BS35 4BD

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Kingsway London WC2B 6AN United Kingdom a Four Brindleyplace Birmingham Midlands B1 2HZ el 03 ene 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 05 dic 2018

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 12 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de David William Bowler como director el 31 jul 2018

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 023796950008

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Arthur Harold Moore como director el 30 jun 2018

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Bridge Access Road Aust South Gloucestershire BS35 4BD a 1 Kingsway London WC2B 6AN el 13 jun 2018

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 08 ene 2018

    32 páginasAA

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2017 au 08 ene 2018

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Pierre-Louis Delseny como director el 31 ene 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 12 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Stephen Pearson el 06 sept 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr David Jon Rushton el 21 ago 2017

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Ryan Paul Hayward como director el 11 abr 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Andrew Logue como director el 11 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    33 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jiten Mistry como director el 03 mar 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Marc Marie Joseph Neyrand como director el 12 ene 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RAWLE, James Alexander
    Bridge Access Road
    BS35 4BD Aust
    Severn River Crossing Plc
    South Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    Bridge Access Road
    BS35 4BD Aust
    Severn River Crossing Plc
    South Gloucestershire
    United Kingdom
    British65087010002
    HAYWARD, Ryan Paul
    One Churchill Place
    E14 5HP London
    Level 29
    England
    Director
    One Churchill Place
    E14 5HP London
    Level 29
    England
    EnglandBritishBanker230297320001
    MISTRY, Jiten
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker226325760001
    NEYRAND, Marc Marie Joseph
    Rue Louis Bleriot
    92500 Rueil-Malmaison
    12-14
    France
    Director
    Rue Louis Bleriot
    92500 Rueil-Malmaison
    12-14
    France
    FranceFrenchDirector225554460001
    PEARSON, Andrew Stephen
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Ltd / 1
    United Kingdom
    Director
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Ltd / 1
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector91780000002
    RUSHTON, David Jon
    1 Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Limited
    United Kingdom
    Director
    1 Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Director146861390008
    SINGH, Siddharth
    2 King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    Bank Of America Merrill Lynch
    England
    Director
    2 King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    Bank Of America Merrill Lynch
    England
    EnglandIndianDirector199127930001
    SNOW, Henry
    Astral House
    Imperial Way
    WD24 4WW Watford
    Vinci Concessions
    Hertfordshire
    England
    Director
    Astral House
    Imperial Way
    WD24 4WW Watford
    Vinci Concessions
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector200064790001
    FEATHERSTONE, Derek William
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British38485580001
    ARMSTRONG, James
    Olde Tyles
    Camp Road
    SL9 7PE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Olde Tyles
    Camp Road
    SL9 7PE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishAccountant41035300001
    ARMSTRONG, Peter Richard
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Ltd / 1
    United Kingdom
    Director
    Kingsway
    WC2B 6AN London
    John Laing Investments Ltd / 1
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director57858480002
    BATTERSBY, Adam Paul
    Bridge Access Road
    Aust
    BS35 4BD South Gloucestershire
    Director
    Bridge Access Road
    Aust
    BS35 4BD South Gloucestershire
    UkBritishVice President, Strategic Investments, Baml151406280001
    BEATRIX, Marc Charles Marie
    11 Rue Saint Matthieu
    78550 Houdan
    France
    Director
    11 Rue Saint Matthieu
    78550 Houdan
    France
    FrenchFinance Director51928050001
    BEER, Christopher Paul Constantine
    Hartford House
    Rotherwick
    RG27 9BD Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hartford House
    Rotherwick
    RG27 9BD Basingstoke
    Hampshire
    BritishBanker30112110001
    BOWLER, David William
    Astral House
    Imperial Way
    WD24 4WW Watford
    Vinci Plc
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Astral House
    Imperial Way
    WD24 4WW Watford
    Vinci Plc
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor34940010004
    BOWLER, David William
    Watling Lane
    OX10 7JG Dorcester On Thames
    14
    Oxon
    Director
    Watling Lane
    OX10 7JG Dorcester On Thames
    14
    Oxon
    United KingdomBritishSolicitor34940010004
    BREEM, Gilles Pierre Yves
    16 Allee Des Soudanes
    78430 Louveciennes
    France
    Director
    16 Allee Des Soudanes
    78430 Louveciennes
    France
    FranceFrenchSenior Vice President172689100001
    BRESOLIN, Antoine
    Rue De Vaucouleurs
    75011 Paris
    17
    Paris
    France
    Director
    Rue De Vaucouleurs
    75011 Paris
    17
    Paris
    France
    FrenchDirector128748800001
    BURGARD, Louis-Roch
    1 Cours Ferdinand De Lesseps
    Rueil Malmaison
    92851 Cedex
    Vinci Concessions
    France
    France
    Director
    1 Cours Ferdinand De Lesseps
    Rueil Malmaison
    92851 Cedex
    Vinci Concessions
    France
    France
    FranceFrenchDirector147849950001
    CAVILL, John Ivor
    Bridge Access Road
    Aust
    BS35 4BD South Gloucestershire
    Director
    Bridge Access Road
    Aust
    BS35 4BD South Gloucestershire
    United KingdomBritishAsset Manager165765030001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Director
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant40195710004
    CONWAY, Jonathan Paul
    North Colonnade
    Canary Wharf
    E14 4BB London
    Barclays / 5
    England
    Director
    North Colonnade
    Canary Wharf
    E14 4BB London
    Barclays / 5
    England
    EnglandBritishDirector160362360002
    DAUSSY, Philippe-Emmanuel
    3 Mail De L'Europe
    78170 La Celle Saint Cloud
    France
    Director
    3 Mail De L'Europe
    78170 La Celle Saint Cloud
    France
    FrenchEngineer69893460001
    DE LACERDA TEIXEIRA ECOITO, Joao Paulo
    36 Rue Scheffer
    FOREIGN Paris
    F-75116
    France
    Director
    36 Rue Scheffer
    FOREIGN Paris
    F-75116
    France
    PortugueseDeputy Managing Director Road80887220001
    DELSENY, Pierre-Louis
    Bridge Access Road
    BS35 4BD Aust
    Severn River Crossing Plc
    South Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Bridge Access Road
    BS35 4BD Aust
    Severn River Crossing Plc
    South Gloucestershire
    United Kingdom
    FranceFrenchEngineer85320750001
    ELLIOTT, Christopher James
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritishMerchant Banker31541950004
    ELLIOTT, Christopher James
    C/O Barclays De Zoete Wedd Ltd
    2 Swan Lane
    EC4 London
    Director
    C/O Barclays De Zoete Wedd Ltd
    2 Swan Lane
    EC4 London
    BritishMerchant Banker31541950002
    EVANS, John Elwyn
    Fir Tree Farm South Row
    Redwick
    NP26 3DU Caldicot
    Gwent
    Director
    Fir Tree Farm South Row
    Redwick
    NP26 3DU Caldicot
    Gwent
    BritishDirector118037000001
    EWER, Adrian James Henry
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    Director
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishAccountant33196010002
    FOOT, David Alexander John
    Allington House
    150 Victoria Street
    SW1E 5LB London
    John Laing Investments Limited
    United Kingdom
    Director
    Allington House
    150 Victoria Street
    SW1E 5LB London
    John Laing Investments Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector178302820001
    FRIEND, Andrew Erskine
    1 Priory Crescent
    BN7 1HP Lewes
    East Sussex
    Director
    1 Priory Crescent
    BN7 1HP Lewes
    East Sussex
    EnglandBritishInvestment Manager66359650001
    GIDWANI, Krishna
    2 King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    Bank Of America Merrill Lynch
    Director
    2 King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    Bank Of America Merrill Lynch
    United KingdomUnited StatesInvestor147844140001
    HASTE, Norman David
    3 Over Court Mews
    BS32 4DG Almondsbury
    South Gloucestershire
    Director
    3 Over Court Mews
    BS32 4DG Almondsbury
    South Gloucestershire
    BritishChartered Civil Engineer69499870004
    HOGG, Alan Campbell
    63 Brackley Road
    NN12 6DH Towcester
    South Northamptonshire
    Director
    63 Brackley Road
    NN12 6DH Towcester
    South Northamptonshire
    EnglandBritishProject Finance Manager74271800002
    HOOSON, Hugh Emlyn, Lord
    Summerfield Park
    Llanidloes
    SY18 6AQ Powys
    Director
    Summerfield Park
    Llanidloes
    SY18 6AQ Powys
    BritishQueens Council31541960001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SEVERN RIVER CROSSING PLC?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    12 nov 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene SEVERN RIVER CROSSING PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 04 jun 2015
    Entregado el 09 jun 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Trustees of the Severn River Crossing PLC Pension Fund
    Transacciones
    • 09 jun 2015Registro de una carga (MR01)
    • 30 jul 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 jul 2013
    Entregado el 09 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    1) except as prohibited under the concession agreement, the freehold and leasehold property of the company both present and future, all buildings and fixtures, fixed plant and machinery from time to time on any such property and all liens, mortgages, charges, options, agreements and rights, titles and interests of the company in or over land of whatever description both present and future;. 2) all the right, title and interest of the company in all fixed plant and machinery on any freehold or leasehold property forming part of the charged property from time to time hired, leased or rented by the company from third parties or acquired by the company from third parties on a hire, instalment or conditional purchase basis including the company's right to any refund of rentals or other payments;. 3) the intellectual property rights as defined in the charge dated 1 july 2013.. 4) all other plant and machinery, fittings and equipment now or at any time hereafter belonging to the company or in which the company is legally, beneficially or otherwise interested, wherever situated and whether or not affixed to any freehold or leasehold property of the company. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 01 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A second priority supplemental fixed and floating charge debenture
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the company to the stockholders (or any of them) or the trustees under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Company Limited as Trustee for Itself and the Stockholders
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A third priority supplemental fixed and floating charge debenture
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Transport
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 28 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    First priority supplemental fixed and floating charge debenture
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 21 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America Securities Limited (As Trustee for the First Ranking Creditors)
    Transacciones
    • 21 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Second priority fixed & floating charge debenture
    Creado el 29 oct 1990
    Entregado el 09 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £131,000,000 6 % index linked debenture stock of the company and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 29.10.90
    Breve descripción
    (Please see doc M397 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 09 nov 1990Registro de una carga
    • 15 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    First priority fixed & floating charge debenture
    Creado el 29 oct 1990
    Entregado el 08 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the first ranking creditors (as defined) under the terms of the banks facility agreement, the eib facility agreement and the swap liabilities (as defined)
    Breve descripción
    (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of America International Limited
    Transacciones
    • 08 nov 1990Registro de una carga
    • 22 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Third priority fixed & floating charge debenture.
    Creado el 29 oct 1990
    Entregado el 07 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the financing agreements (as defined)
    Breve descripción
    (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Transport.
    Transacciones
    • 07 nov 1990Registro de una carga
    • 15 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene SEVERN RIVER CROSSING PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 dic 2018Inicio de la liquidación
    08 sept 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Michael Hawes
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Profesional
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0